CRANMER COURT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CRANMER COURT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04809306 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CRANMER COURT LIMITED?
- Pflegeheime für ältere und behinderte Menschen (87100) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich CRANMER COURT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CRANMER COURT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
WARLINGHAM HOME (SITE) LIMITED | 27. Juni 2003 | 27. Juni 2003 |
WALLINGHAM HOME (SITE) LIMITED | 24. Juni 2003 | 24. Juni 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CRANMER COURT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CRANMER COURT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 20. Juli 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP zum Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD am 05. Aug. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Jonathan David Farkas als Direktor am 27. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mathieu Streiff als Geschäftsführer am 27. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 28 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mathieu Streiff am 31. März 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sanne Group Secretaries (Uk) Limited am 31. März 2014 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London W1J 8DJ United Kingdom* am 07. Apr. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2014 bis 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CRANMER COURT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Sekretär | Palmer Street SW1H 0AD London 21 United Kingdom |
| 175738460001 | ||||||||||
FARKAS, Jonathan David | Geschäftsführer | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor | Luxembourg | American | Managing Director | 193539990001 | ||||||||
JEFFERY, Paul Anthony Keith | Sekretär | Stable House Cockaynes Lane Alresford CO7 8BZ Colchester Essex | British | Accountant | 65609290003 | |||||||||
SCHOFIELD, Nigel Bennett | Sekretär | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
GRIFFIN, Craig | Geschäftsführer | Halebourne House Halebourne Lane GU24 8SL Chobham Surrey | United Kingdom | British | Nursing Home Operator | 154122490001 | ||||||||
HILL, Peter Martin | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | Accountant | 130983750002 | ||||||||
JEFFERY, Paul Anthony Keith | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | Accountant | 65609290003 | ||||||||
SCHOFIELD, Nigel Bennett | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | Solicitor | 148139420001 | ||||||||
STREIFF, Mathieu Bernard | Geschäftsführer | c/o Sanne Group 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor Pollen House | United States | American | Attorney | 200529310001 | ||||||||
WHITE, Ian James | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | Accountant | 133383410003 | ||||||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CRANMER COURT LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06. Apr. 2016 | 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CRANMER COURT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 28. Juli 2010 Geliefert am 06. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2007 Geliefert am 27. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 21. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Moorcroft nursing home,old farleigh road,warlingham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 19. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Dez. 2003 Geliefert am 22. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a moorcroft nursing home old farleigh road warlington surrey t/n's SY322104 and SY214508. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0