CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04813092 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROOMCO (3230) LIMITED | 27. Juni 2003 | 27. Juni 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Sept. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Apr. 2011 | 9 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tulip House Craven Court Willie Snaith Road Newmarket England CB8 7FA England am 29. Apr. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 11 Seiten | MG01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Oaks Lodge Fordham Road Newmarket Suffolk CB8 7XN am 14. Nov. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2007 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOSEC LIMITED | Sekretär | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| LYNAM, Robert Iain | Geschäftsführer | Beech House 9 Pendennis Road TN13 3JS Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 1374130001 | |||||
| SULLIVAN, Sean Patrick | Geschäftsführer | Rustat Avenue CB1 3PF Cambridge 29 Cambridgeshire | United Kingdom | British | 137653030001 | |||||
| ROTH, David John | Sekretär | 10 Lime Close CB5 0JR Burwell Cambridgeshire | German | 154094310001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| BEARD, James Ian | Geschäftsführer | The Walnuts High Street Wendy SG8 0HG Royston Hertfordshire | British | 36202130001 | ||||||
| ETHERINGTON, Andreas | Geschäftsführer | 8 Garrod Approach IP12 1TD Melton Suffolk | United Kingdom | British | 168050580001 | |||||
| MAHADEVAN, Joshua Rabindranath | Geschäftsführer | 19 Manston Drive CM23 5EJ Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52916580001 | ||||||
| MCKENNA, Christopher | Geschäftsführer | 3 Midhurst Close IP32 7NH Bury St. Edmunds Suffolk | British | 57816210002 | ||||||
| MCLEAN, Anthony | Geschäftsführer | Woodlands Cage End, Hatfield Broad Oak CM22 7HP Bishops Stortford | United Kingdom | British | 67231420002 | |||||
| MORRIS, George Eryl | Geschäftsführer | Broad Oak Devonshire Avenue HP6 5JE Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 10280180001 | |||||
| ROTH, David John | Geschäftsführer | 10 Lime Close CB5 0JR Burwell Cambridgeshire | England | German | 154094310001 | |||||
| SKULL, Amanda Sarah Osborne | Geschäftsführer | Steggles Barn Whiting Street IP33 1NR Bury St Edmunds | England | British | 86782960002 | |||||
| SMITH, Nigel Grant | Geschäftsführer | 2 Meadow Drive Horringer IP29 5SB Bury St Edmunds Suffolk | British | 54325850001 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Hat CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture with floating charge | Erstellt am 14. Dez. 2009 Geliefert am 23. Dez. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Okt. 2007 Geliefert am 23. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 2005 Geliefert am 08. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CARE PRINCIPLES GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0