MANVIK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMANVIK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04816375
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MANVIK LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich MANVIK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o FRP ADVISORY LLP
    2nd Floor Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St. Albans
    Hertfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MANVIK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MANVIK HIRE LIMITED01. Juli 200301. Juli 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANVIK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2009

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MANVIK LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MANVIK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    10 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2014

    11 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2013

    9 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Apr. 2012

    12 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 49 London Road St Albans AL1 1LJ* am 17. Feb. 2012

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Nov. 2011

    9 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    26 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    26 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Barn 2 Dunston Business Village Stafford Road Dunston Staffordshire ST18 9AB* am 31. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Graham Jones als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Raymond Mcsorley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Ryan Cunningham als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Phillip Kershaw als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Kershaw als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Kershaw als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Phillip Kershaw als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    5 SeitenMG01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Mr Raymond Alphonsus Mcsorley als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Power als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Juli 2010

    Kapitalaufstellung am 07. Juli 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von MANVIK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CUNNINGHAM, Ryan
    c/o Frp Advisory Llp
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St. Albans
    2nd Floor Trident House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    c/o Frp Advisory Llp
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St. Albans
    2nd Floor Trident House
    Hertfordshire
    IrelandIrishDirector157156980001
    DELANEY, Deborah
    Avonlea
    Demesne
    IRISH Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Sekretär
    Avonlea
    Demesne
    IRISH Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Irish25176490001
    DOLAN, Evan
    10 Laragh
    Killiney Avenue
    IRISH Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Sekretär
    10 Laragh
    Killiney Avenue
    IRISH Killiney
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant126486530001
    JONES, Graham
    Stafford Road
    ST18 9AB Dunston
    Barn 2 Dunston Business Village
    Staffordshire
    Sekretär
    Stafford Road
    ST18 9AB Dunston
    Barn 2 Dunston Business Village
    Staffordshire
    148650110001
    KERSHAW, Alan
    2 Coldwater Lakes
    Saggart
    Dublin
    Ireland
    Sekretär
    2 Coldwater Lakes
    Saggart
    Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director91550860001
    MAPLE SECRETARIES LIMITED
    Upper Mount Street
    Dulin
    39-40
    Co Dublin
    Ireland
    Sekretär
    Upper Mount Street
    Dulin
    39-40
    Co Dublin
    Ireland
    141003780001
    BURGESS, Mark Philip
    Birch House
    Hernes Nest
    DY12 2ET Bewdley
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Birch House
    Hernes Nest
    DY12 2ET Bewdley
    Worcestershire
    BritishCompany Director91535540001
    BYRNE, Wayne
    Rathcoffey Demesne
    Rathcoffey
    Castleform House
    Kildare
    Ireland
    Geschäftsführer
    Rathcoffey Demesne
    Rathcoffey
    Castleform House
    Kildare
    Ireland
    IrelandIrishManaging Director156497490001
    DELANEY, Brendan
    Avonlea
    Demesne
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Avonlea
    Demesne
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrelandChartered Secretary144016790001
    DOLAN, Evan
    10 Laragh
    Killiney Avenue
    IRISH Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    10 Laragh
    Killiney Avenue
    IRISH Killiney
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant126486530001
    KERSHAW, Mark
    Dunston Business Village
    Dunston
    ST18 9AB Stafford
    Barn 2b
    Geschäftsführer
    Dunston Business Village
    Dunston
    ST18 9AB Stafford
    Barn 2b
    IrelandIrishDirector141003630001
    KERSHAW, Mark
    Coldwater Lakes
    Saggart
    14
    Co.Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Coldwater Lakes
    Saggart
    14
    Co.Dublin
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director141003630001
    KERSHAW, Phillip
    Stafford Road
    ST18 9AB Dunston
    Barn 2 Dunston Business Village
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Stafford Road
    ST18 9AB Dunston
    Barn 2 Dunston Business Village
    Staffordshire
    IrelandIrishDirector155317140001
    KERSHAW, Phillip
    Coldwater Lakes
    Saggart
    15
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Coldwater Lakes
    Saggart
    15
    Co Dublin
    Ireland
    IrishSales Executive141003700001
    MCSORLEY, Raymond Alphonsus
    Stafford Road
    ST18 9AB Dunston
    Barn 2 Dunston Business Village
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Stafford Road
    ST18 9AB Dunston
    Barn 2 Dunston Business Village
    Staffordshire
    Northern IrelandBritishDirector81441760002
    POWER, Anthony Joseph
    Greenways
    2D5 0BN Abbots Langley
    26
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Greenways
    2D5 0BN Abbots Langley
    26
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector138629400001
    RYAN, Martin
    16 Oatfield Park
    Clane
    County Kildare
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    16 Oatfield Park
    Clane
    County Kildare
    Republic Of Ireland
    IrishCompany Director110580120001

    Hat MANVIK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge by way of debenture
    Erstellt am 14. Okt. 2010
    Geliefert am 20. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Invoice Finance LTD
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 01. Juni 2006
    Geliefert am 13. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the companys rights title and interest in sub-hire agreements and related contracts at any time entered into in respect of the goods and in any other contracts at any time entered in to in respect of such goods all the companys rights title and interest in the sub-hire agreements from time to time briefly described in the supplementary schedules executed pursuant to the deed and all related contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 13. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture (charge on hire contracts)
    Erstellt am 06. Jan. 2006
    Geliefert am 11. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Monies due to the company under rental agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paccar Financial Limited
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge and assignment of sub-agreements
    Erstellt am 13. Dez. 2005
    Geliefert am 15. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sub-agreements being 1) oxford cc, dennis eagle phoenix 2-23W refuse body mounted to an elite 6X4 wide chassis, r/no SA93004WN5W047331; 2) oxford cc, otto evolution tdm trade hoist mounted to the above chassis, r/no 3P4113B. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplementary schedule
    Erstellt am 26. Okt. 2005
    Geliefert am 29. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights title and interest in the sub-hire agreements described in the schedule to the deed and all related contracts (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge and assignment of sub-agreements
    Erstellt am 12. Juni 2005
    Geliefert am 22. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All existing and future agreements including 1) l b hackney dennis 6X2 narrow trade r/no 0000011354, 2) l b hackney dennis 6X2 narrow trade r/no 0000011357. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. März 2005
    Geliefert am 09. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 09. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Erstellt am 08. Feb. 2005
    Geliefert am 10. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in sub-leases in respect of goods comprised in hp leasing or hire agreements together with the benefit of all collateral agreements, guarantees, indemnities, negotiable instruments, securities and insurance policies in connection with the agreements.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Asset sub-hire agreement
    Erstellt am 01. Feb. 2005
    Geliefert am 04. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge
    Erstellt am 30. Juli 2004
    Geliefert am 20. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first specific equitable mortgage all present and future contracts of lease or hire in relation to all or any goods acquired, all monies now or from time to time payable to the company thereunder and any proceeds of sale or insurance monies received. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC T/a Allied Irish Bank (GB)
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat MANVIK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Mai 2011Beginn der Verwaltung
    17. Apr. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael William Young
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire
    Praktiker
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire
    Peter Nicholas Wastell
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire
    Praktiker
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire
    2
    DatumTyp
    17. Apr. 2012Beginn der Liquidation
    15. Aug. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael William Young
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire
    Praktiker
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire
    Peter Nicholas Wastell
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire
    Praktiker
    Frp Advisory Llp Trident House
    42-48 Victoria Street
    AL1 3HZ St Albans
    Hertfordshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0