ASHBOURNE LIFE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASHBOURNE LIFE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04818111 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASHBOURNE LIFE LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich ASHBOURNE LIFE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASHBOURNE LIFE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASHBOURNE LIFE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 31. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor am 31. Aug. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASHBOURNE LIFE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVETT, David Charles | Geschäftsführer | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | 34419700002 | |||||
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| KIME, Sean Thomas | Sekretär | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304790001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FARMER, Nicholas John | Geschäftsführer | 62 Freshwater Close Great Sankey WA5 3PU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 124228290001 | |||||
| FEARN, Lynn | Geschäftsführer | Elmwood Drive DE55 7QJ Alfreton 24 Derbyshire | United Kingdom | British | 130867640001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Geschäftsführer | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | 17 Lower Castle Street NP7 5EE Abergavenny Monmouthshire | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GEE, Andrew Anthony Edward | Geschäftsführer | 83a Sutherland Avenue TN16 3HG Biggin Hill Kent | England | British | 93592160001 | |||||
| GOSLING, Mark David | Geschäftsführer | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Geschäftsführer | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MACINTOSH, Michael | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 137864880001 | |||||
| MALHAM, Janette | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 91088900004 | |||||
| MCKEEVER, Pauline Ann | Geschäftsführer | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | 91521130001 | |||||
| MCKEEVER, Pauline Ann | Geschäftsführer | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | 91521130001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| POYNTON, Ellen | Geschäftsführer | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | United Kingdom | British | 89071020004 | |||||
| PRESTON, Mary | Geschäftsführer | 1 Pall Mall Cottage Rivington Lane BL6 7RY Bolton | United Kingdom | British | 124068010001 | |||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| STOREY, John | Geschäftsführer | 93 Dacre Park Blackheath SE13 5BX London | British | 60123860002 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
Hat ASHBOURNE LIFE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 17. Sept. 2004 Geliefert am 21. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a lauriston house, bickley park road, bickley, bromley t/no SGL646394. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 17. Sept. 2004 Geliefert am 21. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a burgess house, 77-85 newport road, cardiff t/no CYM135710. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 17. Sept. 2004 Geliefert am 21. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a markfield court, ratby lane, markfield, leicestershire t/no LT356040. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 11 february 2005 and | Erstellt am 22. Juli 2004 Geliefert am 02. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The lease of all and whole the subjects comprising eastwood court eastwoodmains road giffnock glasgow t/n REN39281 REN39484 and REN6863,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 11 february 2005 and | Erstellt am 22. Juli 2004 Geliefert am 02. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The lease of all and whole the subjects comprising warren park nursing home anthony road largs t/n AYR35522,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH february 2005 and | Erstellt am 22. Juli 2004 Geliefert am 26. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The subjects comprising warren park nursing home, anthony road, largs t/no AYR35522. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 11TH february 2005 and | Erstellt am 22. Juli 2004 Geliefert am 26. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the property k/a eastwoodmains road, giffnock, glasgow t/nos REN39281, and REN39484 and REN6863. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 11 may 2004 and | Erstellt am 30. Apr. 2004 Geliefert am 21. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The lease dated 1 and 2 february under t/no ren 86157 of all and whole the subjects comprising eastwood court eastwoodmains road giffnock glasgow t/no's REN39281, ren 39484 and ren 6863. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 11/05/04 and | Erstellt am 30. Apr. 2004 Geliefert am 21. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole the subjects comprising warren park nursing home anthony road largs t/n AYR35522. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 30. Apr. 2004 Geliefert am 13. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H properties known as markfield court, ratby lane, markfield, leicestershire, t/no LT350435, lauriston house, bickley park road, bromley t/no SGL587121 and burgess house, 77-85 newport road, caridff t/no WA798401 including all fixtures on such property; book debts; goodwill; uncalled captial. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Juli 2003 Geliefert am 18. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ASHBOURNE LIFE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0