PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04821735 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Prologis House, Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Aug. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of Pelp Uk Holdco Limited as a person with significant control on 02. Aug. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Norges Bank as a person with significant control on 02. Aug. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Andrew Donald Griffiths als Geschäftsführer am 10. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Paul David Weston als Direktor am 01. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Monkspath Hall Road Solihull West Midlands B90 4FY zum Prologis House, Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull B90 8AH am 30. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Nicholas David Mayhew | Sekretär | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | British | Lawyer | 127095010001 | |||||
SMITH, Nicholas David Mayhew | Geschäftsführer | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | England | British | Lawyer | 127095010001 | ||||
WESTON, Paul David | Geschäftsführer | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | England | British | Chartered Surveyor | 139192210001 | ||||
STEPHENSON, Mark William | Sekretär | 3 Spring Meadows Close Bilbrook WV8 1GJ Codsall Staffordshire | British | 82815550001 | ||||||
HAMMONDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham West Midlands | 73037780002 | |||||||
HAMMONDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580008 | |||||||
GRIFFITHS, Andrew Donald | Geschäftsführer | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | United Kingdom | British | Managing Director | 56528380010 | ||||
LEE, Brian Martin | Geschäftsführer | Highwood Duddenhoe End CB11 4UT Saffron Walden Essex | England | British | Head Of Office | 10106190003 | ||||
LEWIS, Mark Andrew | Geschäftsführer | 169 Longdon Road Knowle B93 9HY Solihull Penn Fields | England | British | Financial Controller | 135597890002 | ||||
STEPHENSON, Mark William | Geschäftsführer | 3 Spring Meadows Close Bilbrook WV8 1GJ Codsall Staffordshire | England | British | Company Secretary | 82815550001 | ||||
WILLING, Paul James | Geschäftsführer | Rotherwood Rue De L'Eglise JE3 4BA St John Jersey Je3 4ba | British | Chartered Accountant | 89632310001 | |||||
HAMMONDS DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 73774730003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelp Uk Holdco Limited | 02. Aug. 2022 | Blythe Gate Shirley B90 8AH Solihull Prologis House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Norges Bank | 11. Juli 2016 | Sentrum Olso Bankplassen 2 0151 Oslo Norway | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 6 ZONE A (NO.2) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Master receivables pledge agreement | Erstellt am 09. Feb. 2012 Geliefert am 15. Feb. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Present and future claims rights title and interest in the loan receivables see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 09. Feb. 2012 Geliefert am 15. Feb. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the legal assetco guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Unit 6 zone a cheaney drive grange park northampton t/no NN237960 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees and warranties. Fixed charge all accounts, the intellectual property and all monetary claims. Floating charge the undertaking and its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0