VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED

VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04825441
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED?

    • Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    26 Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INFRARED ACTIVE PROPERTY FUND NOMINEE LIMITED30. März 201130. März 2011
    HSI ACTIVE PROPERTY FUND NOMINEE LIMITED13. Aug. 200313. Aug. 2003
    PIXIEDALE LIMITED08. Juli 200308. Juli 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Martin Hamlton Croft-Sharland am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Ms Teresa Laura Harriet Gilchrist am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Jenkins am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Matthew Mackenzie Cheyne am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Charles Anthony Alcock am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Jenkins am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Teresa Laura Harriet Gilchrist am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Charles Anthony Alcock am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 01. Jan. 2017

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Martin Hamilton Croft-Sharland am 20. Juni 2016

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Teresa Laura Harriet Gilchrist am 25. März 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 08. Juli 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Ernennung von Matthew Mackenzie Cheyne als Direktor am 22. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Jenkins am 18. Aug. 2014

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PEARMAN, Thomas Joseph
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    British174729010001
    ALCOCK, Charles Anthony
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish141993640001
    CHEYNE, Matthew Mackenzie
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish96872290001
    CROFT-SHARLAND, Richard Martin Hamlton
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish210167330001
    FRASER, Hugh Macpherson Cameron
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    NetherlandsBritish157004960002
    GILCHRIST, Teresa Laura Harriet
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish142404820005
    JENKINS, John Andrew
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish106703980001
    PEARMAN, Thomas Joseph
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish104558060004
    JENKINSON, Louisa Jane
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    Sekretär
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    British106060330002
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MILLER, Philip
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    Sekretär
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    British121053850001
    OWEN, Stephen
    Clayton Croft Road
    Wilmington
    DA2 7AU Kent
    11
    United Kingdom
    Sekretär
    Clayton Croft Road
    Wilmington
    DA2 7AU Kent
    11
    United Kingdom
    Other132334270001
    WYLLIE, Alison
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Sekretär
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    British107811220001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BOND, Iain Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish68687180001
    DE ALBUQUERQUE, Simon Peter
    15 Fielding Mews
    Barnes
    SW13 9EY London
    Geschäftsführer
    15 Fielding Mews
    Barnes
    SW13 9EY London
    EnglandBritish150525130001
    GLOVER, Edward Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish121380002
    GUIONNEAU, Werner Marc Friedrich Von
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomGerman110089200002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MACKEY, Paul Emmanuel
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomIrish11264820014
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Geschäftsführer
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritish162620820001
    THORP, Timothy Geoffrey
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish66923730003
    TSOUROUS, Lucy Anna
    87 Elgin Mansions
    Elgin Avenue Maida Vale
    W9 1JN London
    Geschäftsführer
    87 Elgin Mansions
    Elgin Avenue Maida Vale
    W9 1JN London
    British63852340001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    08. Juli 2016Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat VBR INVESTMENTS NOMINEE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 06. Feb. 2014
    Geliefert am 11. Feb. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    F/H friars court and the friary, rickfords hill, aylesbury t/no BM225191. F/h boundary house, 4 county place, chelmsford t/no EX516848. F/h block k, technology drive, beeston, nottingham t/no NT389245. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Deed of assignment of building contract and agreement for lease
    Erstellt am 05. Dez. 2007
    Geliefert am 11. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2007
    Geliefert am 01. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The insurances and the future easements and other rights in connection with the property being f/h property on the north side of fortran road st mellons business park cardiff t/no WA741238. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juni 2007
    Geliefert am 06. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit j southern cross industrial estateshripney road bognor regis t/no WSX296186 and part of the land on the east side. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 06. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. März 2007
    Geliefert am 21. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H elmbridge court longlevens glouceste. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 21. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 2007
    Geliefert am 23. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 162 high street chatham t/n K522708 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 2007
    Geliefert am 23. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a friars court and the friary rickfords hill aylesbury t/n BM225191 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 2007
    Geliefert am 23. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a unit 1 links court links business park fortran road st mellons cardiff t/n WA758259 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 74, 76, 78 and 80 peach street and 19, 20 and 21 cross street, wokingham t/no BK139803. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H st georges house, 3 st georges place and 11 church street, twickenham t/no SGL237296. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H adelaide house, adelaide street, st albans, hertfordshire t/no HD203603. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H boundary house, county square, new london road, chelmsford t/no EX516848. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 137 and 138 cambridge science park, milton road, cambridge t/no CB212436. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2006
    Geliefert am 11. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 610-612 carrwood road chesterfield industrial estate chesterfield t/n DY48238 and l/h plots 1. 2, 3, and 4 at goldthorpe industrial estate highgate lane goldthorpe. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 25 october 2006 and
    Erstellt am 11. Sept. 2006
    Geliefert am 03. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Maxwelltown works on the north side of alexander street dundee t/no ang 13760.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Sept. 2006
    Geliefert am 26. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a city house, ronsons way, st albans, hertfordshire being part of the land and buildings in t/no HD208158 as was included in the transfer dated 22 may 2006 and which has been allocated t/no HD455064. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 2006
    Geliefert am 02. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property k/a land and buildings at technology drive beeston t/no's NT389245 and NT389246. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being units a b and c portway road oldbuny west midlands t/n WM604535,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being 1 eelbrook avenue bradwell common milton keynes t/n BM223052,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being 49 51 53 55 and 57 high street droitwich t/n HW176209,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being units 1-4 bredgar road gillingham t/n's K774892 and K774909,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being beaver industrial estate midhurst road liphook hampshire t/n HP411513,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being victoria house 18-22 albert street fleet hampshire t/n HP347533,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being units 1 2 and 3 castle meadows industrial estate abergavenny t/n WA780707,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hsi active property fund trustee limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property being manor trading estate armstrong road benfleet essex t/n EX621874,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0