NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04840981 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED?
- Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen
Wo befindet sich NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7 Crown Yard Bedgebury Road Goudhurst TN17 2QZ Cranbrook Kent |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| 04840981 LIMITED | 28. März 2022 | 28. März 2022 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Paul Sellars as a person with significant control on 28. März 2022 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Notification of Edward Craddock Belcher as a person with significant control on 28. März 2022 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed 04840981 LIMITED\certificate issued on 13/05/22 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 430, 5 Spur Road Unit 430 5 Spur Road Isleworth Middlesex TW7 5BD England zum 7 Crown Yard Bedgebury Road Goudhurst Cranbrook Kent TN17 2QZ am 04. Mai 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2021 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2020 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2019 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Juli 2016 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 19 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf administrative Wiederherstellung | 4 Seiten | RT01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed nevis investment company\certificate issued on 28/03/22 | Seiten | CERTNM | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELCHER, Edward Craddock | Sekretär | 242 South Ealing Road Ealing W5 4RP London | Australian | 49651510002 | ||||||
| BELCHER, Edward Craddock | Geschäftsführer | 242 South Ealing Road Ealing W5 4RP London | United Kingdom | Australian | 49651510002 | |||||
| PEMEX SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Vanterpool Plaza Wickhams Quay 1, Road Town FOREIGN Tortola British Virgin Islands | 900031160001 | |||||||
| BELCHER, Amy | Geschäftsführer | 242 South Ealing Road W5 4RP London | Australia | 93112680001 | ||||||
| SELLARS, Paul | Geschäftsführer | White House Withyham TN7 4BT Hartfield East Sussex | England | British | 50761250001 | |||||
| AMERSHAM SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Vanterpool Plaza Wickhams Quay 1, Road Town FOREIGN Tortola British Virgin Islands | 900031180001 | |||||||
| PEMEX SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Vanterpool Plaza Wickhams Quay 1, Road Town FOREIGN Tortola British Virgin Islands | 900031160001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Sellars | 28. März 2022 | Bedgebury Road Goudhurst TN17 2QZ Cranbrook 7 Crown Yard Kent | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Edward Craddock Belcher | 28. März 2022 | Bedgebury Road Goudhurst TN17 2QZ Cranbrook 7 Crown Yard Kent | Nein |
Nationalität: Australian Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat NEVIS NO. 2 (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 21. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 32 & 34 albion street newark on trent nottinghamshire and 242 south ealing road ealing london, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 15. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as 242 south ealing road ealing london t/n MX440229,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 15. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as 32 and 34 albion street newark on trent notts t/n NT397141 and NT393354,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Juni 2006 Geliefert am 07. Juni 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Jan. 2006 Geliefert am 12. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 34 albion street newark t/n NT393354. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 21. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 32 albion street newark t/no NT397141. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0