EEL REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEEL REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04844882
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EEL REALISATIONS LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich EEL REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EEL REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EVANS EASYSPACE LIMITED18. Nov. 200318. Nov. 2003
    FOLDER HOLDER LIMITED24. Juli 200324. Juli 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EEL REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2013
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2014
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für EEL REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis24. Juli 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung07. Aug. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für EEL REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für EEL REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 13. Feb. 2015

    22 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Aug. 2014

    23 Seiten2.24B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed evans easyspace LIMITED\certificate issued on 11/06/14
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 06. Mai 2014

    RES15

    Beendigung der Bestellung von Lynsey Douglas als Sekretär am 16. Mai 2014

    1 SeitenTM02

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    38 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Millshaw, Ring Road Beeston Leeds West Yorkshire LS11 8EG am 04. März 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beschlüsse

    Resolutions
    14 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    accounts-with-accounts-type-

    28 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Mark Bull als Geschäftsführer am 01. Okt. 2013

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 05. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von John Drummond Bell als Geschäftsführer am 13. Juni 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Terence Millington als Geschäftsführer am 17. Apr. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Benjamin Rose als Geschäftsführer am 14. März 2013

    1 SeitenTM01

    accounts-with-accounts-type-

    26 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Brian Stanley Mawhinney als Geschäftsführer am 30. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Thomas Benjamin Rose als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Fry als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von EEL REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TATE, Christopher Ian
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Geschäftsführer
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish73503320001
    COOPER, Bradley George
    5 Sandy Walk
    Bramhope
    LS16 9DW Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Sandy Walk
    Bramhope
    LS16 9DW Leeds
    West Yorkshire
    British94039480002
    DOUGLAS, Lynsey
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Sekretär
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    155296630001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Sekretär
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BELL, John Drummond
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    Geschäftsführer
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    United KingdomBritish63940900003
    BROWN, Justin Ward
    18 Lightfoot Road
    N8 7JN London
    Geschäftsführer
    18 Lightfoot Road
    N8 7JN London
    EnglandBritish117550300001
    BULL, Andrew Mark
    Ladbroke Grove Farm
    Windmill Lane
    CV47 2BW Southam
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Ladbroke Grove Farm
    Windmill Lane
    CV47 2BW Southam
    Warwickshire
    United KingdomBritish92109140001
    COOPER, Bradley George
    5 Sandy Walk
    Bramhope
    LS16 9DW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Sandy Walk
    Bramhope
    LS16 9DW Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish94039480002
    FRY, Christopher John
    18 St James' Road
    TN13 3NQ Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    18 St James' Road
    TN13 3NQ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish116534710001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    MAWHINNEY, Brian Stanley, Rt Hon The Lord
    Butts Lodge Loop Road
    Keyston
    PE28 0RE Huntingdon
    Geschäftsführer
    Butts Lodge Loop Road
    Keyston
    PE28 0RE Huntingdon
    United KingdomBritish111380700001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Geschäftsführer
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    ROSE, Thomas Benjamin
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish243153580001
    STOKES, Thomas Mcnair
    Moonfleet
    Hallfield Lane
    LS22 6JS Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Moonfleet
    Hallfield Lane
    LS22 6JS Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish93734410001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Hat EEL REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignation of rent
    Erstellt am 26. Jan. 2010
    Geliefert am 27. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's whole right,title and interest in and its rights to receive rents which become payable under or in terms of the leases see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Assignation of rent
    Erstellt am 15. Jan. 2010
    Geliefert am 05. Feb. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's whole right,title and interest in and its rights to receive rents which become payable under or in terms of the lease in relation to the area of ground extending to 0.6443 hectares within the john smith business park kirkaldy fife, know as site 1, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2009
    Geliefert am 04. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right title or interest to or in any land all rental income and any guarantee of rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2009
    Geliefert am 04. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right title or interest to or in any land all rental income and any guarantee of rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Standard security
    Erstellt am 29. Okt. 2009
    Geliefert am 03. Feb. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from evans easyspace limited partnership acting by its general partner evans easyspace limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenants interest in the lease of 0.6443 hectares within the john smith business park kirkcaldy t/n FFE94177.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of charge
    Erstellt am 30. Sept. 2009
    Geliefert am 03. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to any beneficiary and of the chargor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged property and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 06. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right title or interest to or in any land all rental income and any guarantee of rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 06. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 06. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right title or interest to or in any land all rental income and any guarantee of rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 06. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 25. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee or by a receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 4 the eco business park, sheet road, lulow, shropshire.
    Berechtigte Personen
    • Advantage West Midlands
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 2009
    Geliefert am 25. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plots 9 & 10 leominster enterprise park leominster.
    Berechtigte Personen
    • Advantage West Midlands
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Feb. 2009
    Geliefert am 12. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 92 acres at great orchard park rotherwas hereford all rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag,London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Feb. 2009
    Geliefert am 12. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 92 acres at great orchard park rotherwas hereford all rental income see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag,London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2009
    Geliefert am 11. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property being 1.92 acres of land at great orchard park holme lacey road rotherwas industrial estate.
    Berechtigte Personen
    • Advantage West Midlands
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Sept. 2008
    Geliefert am 04. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 1.1 battlesfield enterprise park shrewsbury.
    Berechtigte Personen
    • Advantage West Midlands
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2008
    Geliefert am 25. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a plot 1.1 battlefield enterprise park shrewsbury see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2008
    Geliefert am 25. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a plot 1.1 battlefield enterprise park shrewsbury see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 17. Juli 2008
    Geliefert am 18. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H plots 10 and 11 lakes view international park island road hersden canterbury t/no K9211858; f/h plots 9 and 10 leominster enterprise park leominster t/no HE36599 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 18. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 17. Juli 2008
    Geliefert am 18. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H plots 10 and 11 lakes view international park island road hersden canterbury t/no K9211858; f/h plots 9 and 10 leominster enterprise park leominster t/no HE36599 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 18. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rent
    Erstellt am 28. Apr. 2008
    Geliefert am 03. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's whole right,title and interest in and its rights to receive rents which become payable under or in terms of the leases see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch
    Transaktionen
    • 03. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security
    Erstellt am 25. Apr. 2008
    Geliefert am 03. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenants interest in a lease of subjects plots 2 and 3 easter lnch bathgate west lothian.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch
    Transaktionen
    • 03. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security
    Erstellt am 23. Apr. 2008
    Geliefert am 03. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenants interest in a lease of plot of ground extending to 0.440 hectares lying to the north of harvest road newbridge.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag London Branch
    Transaktionen
    • 03. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2008
    Geliefert am 14. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    T/No WM900574 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Advantage West Midlands
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2008
    Geliefert am 12. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    T/No wm 900574 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Advantage West Midlands
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2009Registrierung einer Belastung
    Supplemental debenture
    Erstellt am 17. Jan. 2008
    Geliefert am 24. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 peter yates manchester road bolton f/h t/no's GM297420, GM599036 and GM585227 the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 17. Jan. 2008
    Geliefert am 24. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 peter yates manchester road bolton f/h t/no's GM297420, GM599036 and GM585227 the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)

    Hat EEL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Feb. 2014Beginn der Verwaltung
    13. Feb. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praktiker
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0