MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04845232 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HAMSARD 2678 LIMITED | 25. Juli 2003 | 25. Juli 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 Berners Street London W1T 3LR England zum 1 More London Place London SE1 2AF am 20. Juli 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 30 Berners Street London W1T 3LR verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 30 Berners Street London W1T 3LR geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Francesca Anne Todd als Direktor am 22. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stefan John Maynard als Geschäftsführer am 27. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Cowan als Geschäftsführer am 27. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Francis Henry Baker als Geschäftsführer am 27. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Francis Henry Baker am 21. Feb. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Sept. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Capita Corporate Director Limited am 15. Juni 2018 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Capita Group Secretary Limited am 15. Juni 2018 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Francis Henry Baker am 15. Juni 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Cowan am 15. Juni 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Sekretär | Berners Street W1T 3LR London 30 England |
| 135207160001 | ||||||||||
| TODD, Francesca Anne | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 72249980003 | |||||||||
| CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Berners Street W1T 3LR London 30 England |
| 129795770003 | ||||||||||
| JONES, Deborah | Sekretär | 27 Holford Way Newton Le Willows WA12 0BZ Warrington Merseyside | British | 96559600001 | ||||||||||
| HAMMONDS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 900026750001 | |||||||||||
| BAKER, Christopher Francis Henry | Geschäftsführer | Berners Street W1T 3LR London 30 England | England | British | 141579190004 | |||||||||
| BEATON, Richard L'Estrange | Geschäftsführer | Prestbury Hall The Village SK10 4BN Prestbury Cheshire | England | British | 97291590001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Neil Richard | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 163983300001 | |||||||||
| CHALONER, Thomas Eric | Geschäftsführer | 5 Dry Hill Park Crescent TN10 3BJ Tonbridge Kent | England | British | 59994380002 | |||||||||
| CHURCHILL, Ian | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 206195420001 | |||||||||
| COLLIER, Michael Patrick | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 182710350001 | |||||||||
| COWAN, James | Geschäftsführer | Berners Street W1T 3LR London 30 England | England | British | 179023640001 | |||||||||
| JONES, Deborah | Geschäftsführer | 27 Holford Way Newton Le Willows WA12 0BZ Warrington Merseyside | United Kingdom | British | 96559600001 | |||||||||
| MAYNARD, Stefan John | Geschäftsführer | Berners Street W1T 3LR London 30 England | England | British | 274905000001 | |||||||||
| MCBRINN, William Stephen | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 161340530001 | |||||||||
| O'BRIEN, Andrew David | Geschäftsführer | Lime Grove Denton M34 3AN Manchester 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 114850390002 | |||||||||
| PARKER, Andrew George | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 115610090003 | |||||||||
| PHILLIPS, Stephen Alan | Geschäftsführer | 264 Portland Street PR8 6LX Southport Merseyside | United Kingdom | British | 96134990001 | |||||||||
| RADFORD, Jamie Leigh | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 193131980001 | |||||||||
| RODGERSON, Craig Hilton | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 188334810001 | |||||||||
| SMALLBONE, Timothy | Geschäftsführer | 8 Low Croft Court Breary Lane Bramhope LS16 9AE Leeds West Yorkshire | England | British | 104386350001 | |||||||||
| HAMMONDS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 900026740001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capita Business Services Ltd | 06. Apr. 2016 | Berners Street W1T 3LR London 30 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Nov. 2010 Geliefert am 16. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 28. Juli 2006 Geliefert am 10. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 2006 Geliefert am 03. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 28. Juli 2006 Geliefert am 03. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from hallco 1328 limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy mortgaged: mr andrew o'brien, date of policy: 08/03/2004, issued by: skandia UK insurance limited, policy number: SP0219571853 and sum assured: £500,000 (exclusive of any bonus). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 28. Juli 2006 Geliefert am 03. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from hallco 1328 limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy mortgaged: mr stephen philips, date of policy: 24/09/2004, issued by: standard life assurance limited, policy number: X75951598 and sum assured: £500,000 (exclusive of any bonus). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 28. Juli 2006 Geliefert am 03. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from hallco 1328 limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy mortgaged: mr richard beaton, date of policy: 28/07/2006, issued by: bupa healthcare assurance limited, policy number: H216014901 and sum assured: £350,000 (exclusive of any bonus). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 14. Jan. 2005 Geliefert am 15. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Skandia protect critical illness policy (with life cover) of mr andrew david o brien dated 1ST of april 2004 policy no CI1019596314 for the term of 5 years sum assured £500,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 27. Okt. 2004 Geliefert am 29. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy together with the beneficial interest. The policy mortgaged being skandia protect critical illness policy (with life cover) of andrew david o'brien policy number CI1019571853 and lifetime protection series level protection plan of mr stephen alan philips policy number X75951598. For further details of the policies charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Feb. 2004 Geliefert am 28. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as hamsard 2678 limited to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Feb. 2004 Geliefert am 27. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and (for so long as they shall hold any loan stock) hsbc growth capital LP and any transferee of the £2,482,585 9 per cent loan stock 2011 of the company constituted by the loan stock instrument of the company dated 20 february 2004 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MICRO LIBRARIAN SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0