PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04859630 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7th Floor 90 High Holborn WC1V 6XX London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PICNICFLOWER LIMITED | 07. Aug. 2003 | 07. Aug. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 05. Apr. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Volaw Trust & Corporate Services Limited am 30. Nov. 2009 | 3 Seiten | CH04 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Volaw Corporate Director One Limited als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Volaw Corporate Director Two Limited als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Ironzar Holdings Ltd als Direktor | 3 Seiten | AP02 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 05. Apr. 2008 | 10 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 05. Apr. 2007 | 10 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 05. Apr. 2006 | 10 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 395 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2005 | 11 Seiten | AA |
Wer sind die Geschäftsführer von PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Don Road JE1 2TR St Helier Templar House Jersey Channel Islands | 117902830002 | |||||||||||||||
IRONZAR HOLDINGS LTD | Geschäftsführer | Don Road JE1 2TR St Helier Templar House Jersey Channel Islands |
| 146403160001 | ||||||||||||||
BUTLER, Alan John | Sekretär | Parklands Queens Drive KT22 0PF Oxshott Surrey | British | Solicitor | 56150360001 | |||||||||||||
LIPSCOMB, Helen | Sekretär | 11 Herbert Road N11 2QN London | British | Executive | 5036040002 | |||||||||||||
MCCARTHY, Martyn Gerald | Sekretär | 26 Dalkeith Road AL5 5PW Harpenden Hertfordshire | British | Director | 93239140001 | |||||||||||||
E Q SECRETARIES JERSEY LIMITED | Sekretär | PO BOX 546 28-30 The Parade JE4 8XY St Helier Channel Islands Channel Islands | 72427310003 | |||||||||||||||
SISEC LIMITED | Sekretär | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 38545840001 | |||||||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||||||
BROWN, Christine Maureen | Geschäftsführer | Maison Des Jumelles La Route De La Haule St Lawrence JE3 1BA Jersey Channel Islands | Jersey, Channel Isles | British | Company Director | 155157410001 | ||||||||||||
CHRISTENSEN, Robert Anthony | Geschäftsführer | Woodlands Court La Route Des Cotils Grouville JE3 9AP Jersey | Jersey | British | Managing Director | 55800150001 | ||||||||||||
COUPE, David John | Geschäftsführer | Lupin Cottage The Green Plumstead NR11 7LV Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Solicitor | 125432970001 | ||||||||||||
HEALEY, Mark Vincent Andrew | Geschäftsführer | Cyrano Cottage La Grande Route De St Pierre JE3 7AY St Peter Channel Islands Channel Islands | British | Director | 116515360001 | |||||||||||||
KALMAN, Melvyn | Geschäftsführer | White Gables Beauport Estate La Route De Genets JE3 8DG St Brelades Jersey | Jersey | British | Company Director | 37290620001 | ||||||||||||
LEONARD, Frances Margaret | Geschäftsführer | Casa Mia Montrose Les Grands Vaux St Saviour JE2 7NA Jersey Channel Islands | British | Director | 106701260001 | |||||||||||||
MERCURY, Kevin Victor | Geschäftsführer | 3 Cherry Hill Court Bellozanne Road St Helier JE2 3SB Jersey | British | Director | 99137080001 | |||||||||||||
NORMAN, Trevor Lennard | Geschäftsführer | 1 Le Jardin De L'Est La Rue Des Buttes JE3 3DG St Mary Jersey Channel Islands | Jersey | British | Director | 150584170001 | ||||||||||||
PERCHARD, Simon Richard | Geschäftsführer | Applecross 7 Springbank Avenue La Vallee Des Vaux JE2 3GW St Helier Channel Islands | United Kingdom | British | Director | 79524970007 | ||||||||||||
PERKINS, John Henry | Geschäftsführer | Colgrain La Longue Rue St Martin JE3 6ED Jersey | British | Director | 74341530003 | |||||||||||||
RAINE, Janet Ann | Geschäftsführer | Olten Villa Pontac Coast Road St Clement JE2 6FW Jersey Channel Islands | British | Director | 110318330001 | |||||||||||||
SCHON, Robert Leonard | Geschäftsführer | 28 St Albans Road NW5 1RD London | England | British | Solicitor | 2738160001 | ||||||||||||
TURNBULL, Timothy William John | Geschäftsführer | Outridge Cottage 8 College Hill Terrace GU27 2JJ Haslemere Surrey | British | Fund Manager | 85445560001 | |||||||||||||
WALSH, Andrew Selby Lister | Geschäftsführer | 6 Welford Place Wimbledon Village SW19 5AJ London | England | British | Corporate Financier | 6967090002 | ||||||||||||
WHEELER, Lorraine Fay | Geschäftsführer | L'Ailette La Rue Des Vignes St Peter JE3 7YL Jersey | Channel Islands | British | Director | 100921140001 | ||||||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||||||
VOLAW CORPORATE DIRECTOR ONE LIMITED | Geschäftsführer | Don Road St Helier JE1 2TR Jersey Templar House Ci | 134358610001 | |||||||||||||||
VOLAW CORPORATE DIRECTOR TWO LIMITED | Geschäftsführer | Don Road St Hekier JE1 2TR Jersey Templar House | 134358780001 |
Hat PRIME LOCATIONS AND PROPERTIES (GP) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security interest agreement | Erstellt am 11. Jan. 2008 Geliefert am 30. Jan. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company acting in its capacity as general partner to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the guarantors right title and interest in all the present and future indebtedness of bullion investments limited to the grantor including the amount of £19,422,515,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security interest agreement | Erstellt am 01. Okt. 2007 Geliefert am 05. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnershp to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The collateral means all the partnerships right title and interest to and in all the present and future indebtedness of the company in the amount of £19,422515. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Okt. 2006 Geliefert am 19. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Sept. 2005 Geliefert am 16. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from borrower a to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 1 undershaft london t/no LN40435. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h l/h and other immovable property all plant machinery vehicles computers and office and other equipment all debts all balances standing to the credit of any account all stocks shares debentures bonds notes and loan capital the goodwill and uncalled capital all copyrights all rental income and by way of floating charge the floating charge property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Jan. 2005 Geliefert am 11. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to all or any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An accounts charge | Erstellt am 26. Jan. 2005 Geliefert am 10. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right,title and interest to and in the transaction accounts and account balances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Jan. 2005 Geliefert am 10. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the security trustee and the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
LP debenture | Erstellt am 14. Nov. 2003 Geliefert am 03. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and samja holdings limited and samja holdings (no. 2) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that f/h property known as 1 undershaft, london EC3 t/n LN40435. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0