MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED

MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04892220
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MASHPOINT LIMITED09. Sept. 200309. Sept. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Allan William Porter als Sekretär am 29. März 2022

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Donagh O'sullivan als Geschäftsführer am 29. März 2022

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Keith Neville Alder-Barber als Geschäftsführer am 25. Jan. 2021

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2020

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Zestplan Limited as a person with significant control on 10. Sept. 2018

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    13 SeitenAA

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2017

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 15. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    12 SeitenAA

    Ernennung von Mr Keith Neville Alder-Barber als Direktor am 15. Dez. 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PORTER, Allan William
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    United KingdomBritishAccountant157440890001
    ALDER BARBER, Neil
    Felmongers
    CM20 3DL Harlow
    132
    Essex
    United Kingdom
    Sekretär
    Felmongers
    CM20 3DL Harlow
    132
    Essex
    United Kingdom
    BritishSite Transportation Manager137491110001
    ANGUS, George David
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    Sekretär
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    British6279030001
    GOURLEY, Alexander
    Roydon Lodge Estate High Street
    Roydon
    CM19 5EF Harlow
    44/45
    Essex
    United Kingdom
    Sekretär
    Roydon Lodge Estate High Street
    Roydon
    CM19 5EF Harlow
    44/45
    Essex
    United Kingdom
    BritishCompany Director137490570001
    PORTER, Allan William
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Sekretär
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    162430870001
    SDG SECRETARIES LIMITED
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    900028430001
    ALDER-BARBER, Keith Neville
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    EnglandBritishProperty Buyer131128350003
    CONWAY, Stephen Stuart Solomon
    Penthouse 5
    Harley House Regents Park
    NW1 5HN London
    Geschäftsführer
    Penthouse 5
    Harley House Regents Park
    NW1 5HN London
    United KingdomBritishCompany Director197472860001
    GOURLEY, Alexander
    Roydon Lodge Estate High Street
    Roydon
    CM19 5EF Harlow
    44/45
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Roydon Lodge Estate High Street
    Roydon
    CM19 5EF Harlow
    44/45
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director137490570001
    O'SULLIVAN, Donagh
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Geschäftsführer
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    EnglandIrishConstruction Director84359770011
    SDG REGISTRARS LIMITED
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    900028420001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    3rd Floor, Sterling House
    England
    09. Sept. 2016
    Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    3rd Floor, Sterling House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer6399519
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MULBERRY PARK INVESTMENT (S.E.) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 2005
    Geliefert am 05. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    30 mulberry business centre quebec way and parking space together with all fixtures and fittings and chattels the goodwill all contracts all rent and other money. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juni 2005
    Geliefert am 22. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 2 mulberry business centre quebec way surrey. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 22. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Mai 2005
    Geliefert am 15. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises known as units 5 & 6 & car parking spaces 5 & 6 units 9 & 10 & car parking spaces 9 & 10 unit 11 & car parking space 11 unit 12 & car parking space 12 together with all fixtures & fittings S. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 15. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 2005
    Geliefert am 13. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H unit 1 mulberry business centre rotherhithe and parking space all fixtures and fittings goodwill compensation payments proceeds of disposal, all development contracts, rents floating charge all moveable plant machinerty implements utensils furniture equipment.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Feb. 2005
    Geliefert am 16. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H k/a unit 4 mulberry park business centre quebec way rotherhithe together with all fixtures and fittings and chattels the goodwill fixed charge over all contracts for the development or dealing of the property first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2005
    Geliefert am 19. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h premises k/a unit 3 mulberyy business centre, london and parking space 3. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 19. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 2004
    Geliefert am 11. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a unit 7 mulberry park business centre and parking space 7, together with all fixtures and fittings and chattels, goodwill, all contracts, any proceeds of the sale and all rent and other money. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Aug. 2004
    Geliefert am 24. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 8 mulberry business centre quebec way surrey dock and car parking space. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 2004
    Geliefert am 16. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 28 & 29 mulberry business centre and parking spaces london, together with all fixtures, fittings and chattels, goodwill, all money received, all contracts for the development or dealing of the property, the rights and interest of the company to any proceeds of sale, all rent and other money,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Apr. 2004
    Geliefert am 16. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 14-18 mulberry business centre and parking spaces london SE16 together with all fixtures and fittings and chattels personal whatsoever the goodwill of any trades or business all money received or to be received by or on behalf of the company in respect of any dealing or disposition with the property or in respect of any compensation or other payment related thereto all contracts the rights and interest of the company to any proceeds of sale all rent and other money from time to time owing or incurred under any occupancy agreements floating charge over all moveable plant machnery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as mulberry park investment (S.E.) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as units 19-27 mulberry business centre surrey quay london together with all fixtures and fittings the goodwill all money received all contracts for the development or dealing of the property the rights and interest of the company first floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time place on or used in the property.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the comapny formerly known as mulberry park investment (S.E.) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All freehold and leasehold property of the company both present and future including any trade fixtures fixed plant and machinery all stocks shares the goodwill and uncalled capital all book and other debts the undertaking and heritable property and all other property and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0