BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED

BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04892803
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    20 Victoria Road
    SL7 1DW Marlow
    Buckinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE BLUESTONE PROPERTY GROUP LIMITED06. Nov. 200306. Nov. 2003
    RIVERCRUSH LIMITED09. Sept. 200309. Sept. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2010
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2010
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis09. Sept. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung23. Sept. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von Russell John Edwards als Geschäftsführer am 20. Nov. 2019

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    COCOMP

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Norris Bazzard & Co Solicitors 119 High Street Amersham Buckinghamshire HP7 0EA United Kingdom* am 16. März 2010

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    9 SeitenAA

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 33 Market Place Henley on Thames Oxfordshire RG9 2AA* am 10. Jan. 2010

    1 SeitenAD01

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    27 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    Verschiedenes

    Section 394
    2 SeitenMISC

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    4 Seiten363a

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    30 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WETHERELL, Ian Sinclair
    Amherst Cottage
    Philip Drive, Flackwell Heath
    HP10 9JB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Amherst Cottage
    Philip Drive, Flackwell Heath
    HP10 9JB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British54772160005
    MAHER, Michael Edward
    Windrush Satwell Close
    RG9 4QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Windrush Satwell Close
    RG9 4QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish110302610001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    EDWARDS, Russell John
    Upper Culham Road
    Upper Culham
    RG10 8NR Reading
    Upper Culham Farm
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Upper Culham Road
    Upper Culham
    RG10 8NR Reading
    Upper Culham Farm
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139428690001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 08. Mai 2009
    Geliefert am 09. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sums deposited from time to time under the terms of the rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Bickleigh Properties Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 2008
    Geliefert am 14. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The malthouse 45 new street henley on thames assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 2008
    Geliefert am 14. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Racquets lankhills road winchester assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 2008
    Geliefert am 14. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Warren court (formerly the garage and coronation house) station road lambourn hungerford assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 2008
    Geliefert am 14. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bluestone point north morte road mortehoe woolacombe assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 2008
    Geliefert am 14. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Norman house norman avenue henley on thames assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Aug. 2008
    Geliefert am 14. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bankside corporation street high wycombe assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. Aug. 2008
    Geliefert am 09. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Share charge
    Erstellt am 27. Jan. 2008
    Geliefert am 05. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and all dividends paid or payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mitre Captial Partners Limited (The Funder)
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 26. Apr. 2007
    Geliefert am 04. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from blue space property eighteen limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All shares all dividends all stocks shares securities rights monies or property accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mitre Capital Partners Limited
    Transaktionen
    • 04. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 16. Feb. 2007
    Geliefert am 26. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All shares to the bank, all dividends paid or payable on all or any of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ansbacher & Co Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 17. Feb. 2005
    Geliefert am 22. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bluestone property eight limited (the "borrower") to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares being two ordinary shares of £1.00 each in the issued share capital of the borrower and registered in the name of the chargor; and all dividends paid or payable on all or any of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ansbacher & Co Limited
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat BLUE SPACE PROPERTY GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Nov. 2009Antragsdatum
    21. Dez. 2009Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Damon K Ray
    D.K. Ray & Co
    20 Victoria Road
    SL7 1DW Marlow
    Buckinghamshire
    Praktiker
    D.K. Ray & Co
    20 Victoria Road
    SL7 1DW Marlow
    Buckinghamshire
    The Official Receiver Or Reading
    3d Apex Plaza
    Forbury Road
    RG1 1AX Reading
    Praktiker
    3d Apex Plaza
    Forbury Road
    RG1 1AX Reading

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0