AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04895923 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AVERY WEIGH-TRONIX NO. 1 LIMITED | 11. Sept. 2003 | 11. Sept. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 23 Seiten | MA | ||||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Juni 2019
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Ryan Ronald Dale als Sekretär am 18. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Matthew Deakin als Geschäftsführer am 30. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen James Rowell am 12. Okt. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Ufland als Geschäftsführer am 13. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Stephen James Rowell als Direktor am 01. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALE, Ryan Ronald | Sekretär | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 | 241474930001 | |||||||||||
| S & J REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England |
| 132600000001 | ||||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Geschäftsführer | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | 161583790003 | |||||||||
| ROWELL, Stephen James | Geschäftsführer | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 | United Kingdom | British | 208316380001 | |||||||||
| FOGARTY, Robert Joseph | Sekretär | April Cottage Manor Lane Little Comberton WR10 3ER Pershore Worcestershire | British | 17437720002 | ||||||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Geschäftsführer | Gresham Street EC2V 7NG London 99 Uk | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| BOWE, Gerald Grant | Geschäftsführer | 85 Pasquaney Lane Bridgewater Nh 03222 Usa | American | 86912720003 | ||||||||||
| CRAMER, Carl, Mr. | Geschäftsführer | 2 Little Dormers South Park Crescent SL9 8HJ Gerrards Cross | United Kingdom | British | 92710960001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Geschäftsführer | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | 146225080003 | |||||||||
| UDALL, Gavin | Geschäftsführer | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Geschäftsführer | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | England | British | 161583570001 | |||||||||
| HUNTSMOOR LIMITED | Geschäftsführer | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 39090660001 | |||||||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Carmelite 50 Victoria Embankment EC4Y 0DX Blackfriars London | 41864110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A V Co 3 Limited | 06. Apr. 2016 | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 31. Juli 2006 Geliefert am 21. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral agreement | Erstellt am 31. Juli 2006 Geliefert am 18. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present and future member of the group (or any of them) to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All capital stock and investment property and all products and proceeds, accessions, stock rights, stock dividends, liquidating dividends, new securities, payments, distributions and proceeds. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 10. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all the shares,all related rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Keyman insurance assignment | Erstellt am 09. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Life assured gerald bowe,sum assured $1,000,000,termination date 27TH september 2048,assurance society protective insurance company,policy number and description life PLO784438 (for further details of life assured see form 395) to assign absolutely its interest in and to the policies and the proceeds and the full benefit thereof as a continuing security to the security trustee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 12. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the holdings or any of its subsidiaries to an agent or to any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0