04906976 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname04906976 LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04906976
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 04906976 LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich 04906976 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 04906976 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Sept. 2015
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Juni 2016
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für 04906976 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis22. Sept. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung06. Okt. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für 04906976 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für 04906976 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von Jay David Laundon als Geschäftsführer am 15. Nov. 2025

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Lee Ballard als Geschäftsführer am 15. Nov. 2025

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Karl Anthony Holt als Geschäftsführer am 15. Nov. 2025

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Mark Beardsley als Geschäftsführer am 18. Dez. 2024

    1 SeitenTM01

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    5 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    SeitenCOCOMP

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed pinnacle developments\certificate issued on 27/07/23
    SeitenCERTNM

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    17 SeitenWU15

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    11 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    10 SeitenWU07

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 24 Landport Terrace Portsmouth Hampshire PO1 2RG zum Allen House 1 Westmead Road Sutton Surrey SM1 4LA am 25. Juli 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Liquidators

    3 SeitenWU04

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 25. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    5 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 30. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Karl Anthony Holt am 01. Sept. 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Mark Beardsley am 01. Sept. 2014

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von 04906976 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LAUNDON, Jay David
    33 St Peters Avenue
    PO11 0SA Hayling Island
    Hampshire
    Sekretär
    33 St Peters Avenue
    PO11 0SA Hayling Island
    Hampshire
    British80603580001
    BREWER, Suzanne
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    Sekretär
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    British85046480001
    BALLARD, Mark Lee
    85 Locksway Road
    PO4 8JW Portsmouth
    Hampshire
    Geschäftsführer
    85 Locksway Road
    PO4 8JW Portsmouth
    Hampshire
    EnglandBritish95278010002
    BEARDSLEY, Nicholas Mark
    Festing Road
    PO4 0NG Southsea
    20
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    Festing Road
    PO4 0NG Southsea
    20
    Hampshire
    England
    EnglandBritish95277980003
    BREWER, Kevin Michael
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    Geschäftsführer
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    United KingdomBritish85029380001
    HOLT, Karl Anthony
    Granada Road
    PO4 0RJ Southsea
    Basement Flat, 46
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    Granada Road
    PO4 0RJ Southsea
    Basement Flat, 46
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish95277960003
    LAUNDON, Jay David
    33 St Peters Avenue
    PO11 0SA Hayling Island
    Hampshire
    Geschäftsführer
    33 St Peters Avenue
    PO11 0SA Hayling Island
    Hampshire
    United KingdomBritish80603580001

    Hat 04906976 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juni 2007
    Geliefert am 20. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Gable cottage chichester ave hayling island,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 12. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4 sea breeze gardens southsea hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2007
    Geliefert am 26. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Yacht haven house copse lane hayling island. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 2007
    Geliefert am 13. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3 dorrita close portsmouth. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Sept. 2006
    Geliefert am 09. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    24 henderson road southsea. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 9 glendower house south parade southsea. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Okt. 2005
    Geliefert am 28. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 lennox road south southsea. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 2004
    Geliefert am 02. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Warrior house, the hard portsmouth PO1 3DT,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Aug. 2004
    Geliefert am 10. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat 04906976 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. März 2016Antragsdatum
    25. Apr. 2016Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Praktiker
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    The Official Receiver Or Southampton
    Spring Place 105 Commercial Road
    SO15 1EG Southampton
    Praktiker
    Spring Place 105 Commercial Road
    SO15 1EG Southampton

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0