EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED

EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04913180
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    16 Seiten4.72

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement liquidator
    10 SeitenLIQ MISC OC

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 15. Jan. 2013

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 18 Buckingham Gate London SW1E 6LB am 21. Dez. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Okt. 2012

    Kapitalaufstellung am 08. Okt. 2012

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Nigel Howard Pope als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Corner als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Nicola Louise Lenthall als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 25. März 2010 bis 31. März 2010

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Russell Taylor als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LENTHALL, Nicola Louise
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    158006330001
    POPE, Nigel Howard
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish29583660002
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish109810150001
    CORNER, Stephen Donald
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    Sekretär
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    British85743480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TAYLOR, Russell John
    Church Road
    NE9 5XE Gateshead
    123
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    Church Road
    NE9 5XE Gateshead
    123
    Tyne And Wear
    EnglandBritish79902420003

    Hat EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property site number BT76/77 nelson park industrial estate northumberland,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 2007
    Geliefert am 20. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a site BT76/77 nelson park industrial estate cramlington any insurances, all gross rents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge
    Erstellt am 17. Nov. 2006
    Geliefert am 21. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 12. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a BT76/73 nelson way, cramlington, northumberland with all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 09. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 09. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H site no. Bt 76/73 nelson park industrial estate cramlington northumberland. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over construction contract
    Erstellt am 13. Sept. 2004
    Geliefert am 23. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future rights title and interest in the construction contract and all sums under the building contract.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over funding agreement
    Erstellt am 18. Mai 2004
    Geliefert am 27. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest to and in and the full benefit of the funding agreement dated 23 april 2004 made between one northeast (1) the company (2) and easter holdings limited (3) relating to the provision of finance for the development to be carried out at site BT76/73 nelson park industrial estate, cramlington, northumberland and all rights and benefits whatsoever in respect of amounts receivable accruing to the company under the funding agreement including all claims for damages in respect of any breach of the funding agreement by any party other than the company.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over building agreement
    Erstellt am 18. Mai 2004
    Geliefert am 27. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Building agreement dated 23 april 2004 made between one northeast (1) the company (2) and easter holdings limited (3) relating to site BT76/73 nelson park industrial estate, cramlington, northumberland and the benefit of all the premises comprised thereon and all buldings for the time being erected thereon and the company's estate and interest therein and by way of assignment all monies due or owing to the company under or by virtue of the building agreement.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 18. Mai 2004
    Geliefert am 27. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking and assets of the company, both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Jan. 2013Beginn der Liquidation
    17. Apr. 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Crawshaw
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Robert Andrew Croxen
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jane Bronwen Moriarty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0