KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04954323 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nuffield House 41-46 Piccadilly W1J 0DS London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TEMPLECO 615 LIMITED | 05. Nov. 2003 | 05. Nov. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Michael Creak am 02. Mai 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Tyler als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 25 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 14 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREAK, Michael | Sekretär | New Park Road GU6 7HL Cranleigh Whitehaven United Kingdom | Other | 118743590001 | ||||||
| HILL, Amanda Jane | Geschäftsführer | Quinton Street Earlsfield SW18 3QS London 60a | United Kingdom | British | 105932470001 | |||||
| MCGANN, Martin Francis | Sekretär | 34 Circus Street Greenwich SE10 8SN London | British | 109383240002 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 16 Old Bailey EC4M 7EG London | 73539310001 | |||||||
| DALE, James Hall | Geschäftsführer | Bradda Brae Bradda East IM9 6QB Port Erin Isle Of Man | Isle Of Man | British | 84675480001 | |||||
| MCGANN, Martin Francis | Geschäftsführer | 34 Circus Street Greenwich SE10 8SN London | England | British | 109383240002 | |||||
| TYLER, Michael Peters | Geschäftsführer | Haydon Park Road SW19 8JH London 99 | British | 108051840001 | ||||||
| TEMPLE DIRECT LIMITED | Geschäftsführer | 16 Old Bailey EC4M 7EG London | 73621250001 |
Hat KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 05. Juli 2007 Geliefert am 24. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged pleasefor details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Okt. 2005 Geliefert am 13. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Okt. 2005 Geliefert am 13. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 19 and 21 bishops hall kingston upon thames t/n SY146474 f/h property k/a 23, 25 and 27 thames street kingston upon thames t/n SGL218890. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. März 2004 Geliefert am 01. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the freehold property being 19 to 27 thames street kingston upon thames and 2 bishops hall kingston upon thames surrey t/n SY146474 & t/n SGL218890 by way of floating charge all the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0