SPACEX (C&M) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPACEX (C&M) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04962649 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPACEX (C&M) LIMITED?
- (4534) /
Wo befindet sich SPACEX (C&M) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ashley House Ashley Road KT18 5AZ Epsom Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPACEX (C&M) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SKYLAW LIMITED | 13. Nov. 2003 | 13. Nov. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPACEX (C&M) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPACEX (C&M) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Gaffney als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Colin Edward Lewis als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Neil Fitzsimmons als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Gaffney am 29. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Lavelle als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Johnson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Joanne Elizabeth Massey als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Robin Simon Johnson am 24. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Gaffney am 13. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Dominic Joseph Lavelle als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Beazer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 36 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPACEX (C&M) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Sekretär | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147807770001 | |||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| BILSLAND, Nicholas James Philip | Sekretär | 22 Watery Lane SW20 9AD London | British | 66511970001 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Sekretär | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| HAINES, Stephen Paul | Sekretär | Long Acre Nutbourne Lane Nutbourne RH20 2HS Pulborough West Sussex | British | 100026510001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| OLLIS, Rachel Anne | Sekretär | 103 The Dell SO15 2PX Southampton Hampshire | British | 91741210001 | ||||||
| BEAZER, Anthony Hadyn | Geschäftsführer | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | 91412650001 | |||||
| BILSLAND, Nicholas James Philip | Geschäftsführer | 22 Watery Lane SW20 9AD London | British | 66511970001 | ||||||
| COLLINS, Susan Ann | Geschäftsführer | Apt 3 Quay 2000 SO17 2NP St Denys Southampton | British | 40335180003 | ||||||
| COOPER, Douglas Anthony | Geschäftsführer | 16 Elan Court Springvale Road Kings Worthy SO23 7LN Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 113817610001 | |||||
| DIPRE, John Vivian | Geschäftsführer | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Geschäftsführer | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| GAFFNEY, David | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Geschäftsführer | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| HAINES, Stephen Paul | Geschäftsführer | Long Acre Nutbourne Lane Nutbourne RH20 2HS Pulborough West Sussex | British | 100026510001 | ||||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MALDE, Nishith | Geschäftsführer | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | United Kingdom | British | 148459300001 |
Hat SPACEX (C&M) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2008 Geliefert am 09. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 11. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a lynes mead tyrells lane burley ringwood t/no HP626928. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Apr. 2005 Geliefert am 11. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Feb. 2005 Geliefert am 11. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Lyes mead tyrells lane burley ringwood. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2005 Geliefert am 14. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0