KILMARTIN (NO.2) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KILMARTIN (NO.2) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04965751 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KILMARTIN (NO.2) LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KILMARTIN (NO.2) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor 17 Grosvenor Gardens SW1W 0BD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KILMARTIN (NO.2) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COLMARTIN (NO.2) LIMITED | 17. Nov. 2003 | 17. Nov. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KILMARTIN (NO.2) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KILMARTIN (NO.2) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Duncan Barclay Roe am 31. Dez. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Princes Gate London SW7 1QJ am 07. Sept. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2010 | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2010 bis 30. Sept. 2010 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2009 | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Whitworth Smallwood am 16. Nov. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Duncan Barclay Roe am 16. Nov. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf administrative Wiederherstellung | 3 Seiten | RT01 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KILMARTIN (NO.2) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIE-SMITH, Derek | Sekretär | 17 South Eaton Place SW1W 9ER London | British | 60313780001 | ||||||
| LUCIE-SMITH, Derek | Geschäftsführer | 17 South Eaton Place SW1W 9ER London | United Kingdom | British | 60313780001 | |||||
| ROE, Duncan Barclay | Geschäftsführer | Bracken Gardens SW13 9HW London 1 | United Kingdom | British | 90999310013 | |||||
| SMALLWOOD, Peter Whitworth | Geschäftsführer | Churchill Gardens SW1V 3BQ London 9 Hungerford House | United Kingdom | British | 4211080010 | |||||
| RICHARDSON, Paul | Sekretär | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||
| ROE, Duncan Barclay | Sekretär | 32 Arundel Terrace Barnes SW13 8DS London | British | 90999310002 | ||||||
| URQUHART, Roderick Macduff | Sekretär | The Hall Samuelston EH41 4HG Haddington E Lothian | British | 562500001 | ||||||
| DWS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023840001 | |||||||
| TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 93 George Street EH2 3ES Edinburgh | 90707230001 | |||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Geschäftsführer | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||
| MCGUINNESS, Neil Stephen | Geschäftsführer | Hazeldean Avenue EH51 0NS Boness 32 West Lothian | United Kingdom | British | 83466350002 | |||||
| MITCHELL, David Frank Robert | Geschäftsführer | 8 East Claremont Street EH7 4JP Edinburgh | British | 97869190001 | ||||||
| TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||
| WOTHERSPOON, Robert John | Geschäftsführer | Glenlyon House Fortingall PH15 2LN Aberfeldy Perthshire | Scotland | British | 161858620001 | |||||
| DWS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023830001 |
Hat KILMARTIN (NO.2) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 10. März 2006 Geliefert am 14. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the lender on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a sitwell house, 11-21 (odd) babington lane, derby t/no DY304457. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 2005 Geliefert am 30. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Nov. 2003 Geliefert am 29. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Nov. 2003 Geliefert am 28. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h property known as sitwell house babbington lane derby t/n DY304457. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0