BUSY BEES GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBUSY BEES GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04968957
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BUSY BEES GROUP LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Busy Bees At St Matthews
    Shaftsbury Drive
    WS7 9QP Burntwood
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROOMCO (3333) LIMITED19. Nov. 200319. Nov. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Struck off register 30/09/2011
    RES13

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beendigung der Bestellung von Adam Loren Cohn als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Maslen als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Elanna Sharon Yalow als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stanley Elliot Maron als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011

    2 SeitenTM01

    Kapitalaufstellung am 29. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 29/09/2011
    RES13

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    7 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    20 SeitenAA

    legacy

    9 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2009 bis 31. Dez. 2009

    1 SeitenAA01

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Sekretär
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    British55976790005
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Geschäftsführer
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Sekretär
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    British9070120002
    WAUGH, John
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    Sekretär
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    New Zealander130463000001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    ANTHONY, Larry
    476 Tweed Valley Way
    Murwillumbah
    New South Wales 2484
    Australia
    Geschäftsführer
    476 Tweed Valley Way
    Murwillumbah
    New South Wales 2484
    Australia
    Australian119252580001
    BANNAN, Jillian Glenda
    47 Tooth Avenue
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Geschäftsführer
    47 Tooth Avenue
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Australian117530620001
    BARBOUR SMITH, James Kenneth Alexander
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British80175630001
    BLACK, James
    103 Howard Street
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Geschäftsführer
    103 Howard Street
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Australian117530480001
    COHN, Adam Loren
    Stone Canyon Road
    Los Angeles
    1221
    California Ca 90077
    Usa
    Geschäftsführer
    Stone Canyon Road
    Los Angeles
    1221
    California Ca 90077
    Usa
    United StatesAmerican179538540001
    GALLAGHER, Patrick
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Geschäftsführer
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Australian130462890001
    HORTON, Mathew
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Geschäftsführer
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Australian130462790001
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Geschäftsführer
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    MARON, Stanley Elliot
    440 21st Street
    Santa Monica
    California 90402
    Usa
    Geschäftsführer
    440 21st Street
    Santa Monica
    California 90402
    Usa
    United StatesAmerican94599720001
    MASLEN, Peter
    Cuscaden Road, #16-01
    Singapore
    20
    249726
    Singapore
    Geschäftsführer
    Cuscaden Road, #16-01
    Singapore
    20
    249726
    Singapore
    SingaporeAustralian138244750001
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    SPOTTISWOODE, Clare Mary Joan
    39 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    Geschäftsführer
    39 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    United KingdomBritish45303770001
    THACKRAY, David Ian
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    British9070100001
    WALSH, Julia Maria, Dr
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    Geschäftsführer
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    UkBritish47545490001
    WAUGH, John
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    Geschäftsführer
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    New Zealander130463000001
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish3850190004
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish3850190004
    YALOW, Elanna Sharon
    Holcomb Avenue
    Larkspur
    427
    California Ca94939
    United States
    Geschäftsführer
    Holcomb Avenue
    Larkspur
    427
    California Ca94939
    United States
    UsaUnited States138244770001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Hat BUSY BEES GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2010
    Geliefert am 30. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental charge
    Erstellt am 04. März 2010
    Geliefert am 06. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and the related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 06. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 09. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession
    Erstellt am 05. Juni 2009
    Geliefert am 16. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Princess christian college wilbraham road fallowfields manchester. Chester street, aston lock south birmingham, land on the west side of manton lane bedford. For further properties please see form 395 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 11. Mai 2005
    Geliefert am 14. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the noteholders or to the trustee (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barrington House Nominees Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 10. Juni 2004
    Geliefert am 24. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 (one) ordinary share of £1 issued by broomco (3347) limited (co no 4968447 together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 24. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    70,000 a ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees hroup limited (co no 3895685); 900 b ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685; 2 c ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 24. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    600,000 ordinary shares of £1.00 each issued by burntwood holdings limited )co no 03840104) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 24. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0