BUSY BEES GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BUSY BEES GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04968957 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BUSY BEES GROUP LIMITED?
- (9305) /
Wo befindet sich BUSY BEES GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Busy Bees At St Matthews Shaftsbury Drive WS7 9QP Burntwood Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BUSY BEES GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROOMCO (3333) LIMITED | 19. Nov. 2003 | 19. Nov. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUSY BEES GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BUSY BEES GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam Loren Cohn als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Maslen als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elanna Sharon Yalow als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stanley Elliot Maron als Geschäftsführer am 29. Sept. 2011 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Sept. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 9 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2009 bis 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BUSY BEES GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONS, Simon Andrew | Sekretär | The Cottage The Grange High Street ST14 8LD Marchington | British | 55976790005 | ||||||
| IRONS, Simon Andrew | Geschäftsführer | The Cottage The Grange High Street ST14 8LD Marchington | England | British | 55976790005 | |||||
| WOODWARD, John Brian | Geschäftsführer | 75 Upper Way Upper Longdon WS15 1QD Rugeley Staffordshire | England | British | 9070090003 | |||||
| RANDLES, Margaret Josephine | Sekretär | 222 Beacon Street WS13 7BH Lichfield Staffordshire | British | 9070120002 | ||||||
| WAUGH, John | Sekretär | Dudley Street 4065 Bardon 35a Queensland Australia | New Zealander | 130463000001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| ANTHONY, Larry | Geschäftsführer | 476 Tweed Valley Way Murwillumbah New South Wales 2484 Australia | Australian | 119252580001 | ||||||
| BANNAN, Jillian Glenda | Geschäftsführer | 47 Tooth Avenue Paddington Queensland Qld 4064 Australia | Australian | 117530620001 | ||||||
| BARBOUR SMITH, James Kenneth Alexander | Geschäftsführer | The Square House Latchmoor Grove SL9 8LN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 80175630001 | ||||||
| BLACK, James | Geschäftsführer | 103 Howard Street Paddington Queensland Qld 4064 Australia | Australian | 117530480001 | ||||||
| COHN, Adam Loren | Geschäftsführer | Stone Canyon Road Los Angeles 1221 California Ca 90077 Usa | United States | American | 179538540001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick | Geschäftsführer | Hawden Street 4051 Wilston 21 Queenstown Australia | Australian | 130462890001 | ||||||
| HORTON, Mathew | Geschäftsführer | Kennedy Terrace 4064 Paddington 50 Queensland Australia | Australian | 130462790001 | ||||||
| IRONS, Simon Andrew | Geschäftsführer | The Cottage The Grange High Street ST14 8LD Marchington | England | British | 55976790005 | |||||
| MARON, Stanley Elliot | Geschäftsführer | 440 21st Street Santa Monica California 90402 Usa | United States | American | 94599720001 | |||||
| MASLEN, Peter | Geschäftsführer | Cuscaden Road, #16-01 Singapore 20 249726 Singapore | Singapore | Australian | 138244750001 | |||||
| RANDLES, Margaret Josephine | Geschäftsführer | 222 Beacon Street WS13 7BH Lichfield Staffordshire | England | British | 9070120002 | |||||
| RANDLES, Margaret Josephine | Geschäftsführer | 222 Beacon Street WS13 7BH Lichfield Staffordshire | England | British | 9070120002 | |||||
| SPOTTISWOODE, Clare Mary Joan | Geschäftsführer | 39 Lonsdale Square N1 1EW London | United Kingdom | British | 45303770001 | |||||
| THACKRAY, David Ian | Geschäftsführer | 37 Burton Old Road WS13 6EN Lichfield Staffordshire | British | 9070100001 | ||||||
| WALSH, Julia Maria, Dr | Geschäftsführer | Wind In The Willows Moorhouse Farm Lane Lower Road UB8 5EN Higher Denham Bucks | Uk | British | 47545490001 | |||||
| WAUGH, John | Geschäftsführer | Dudley Street 4065 Bardon 35a Queensland Australia | New Zealander | 130463000001 | ||||||
| WOODWARD, John Brian | Geschäftsführer | 75 Upper Way Upper Longdon WS15 1QD Rugeley Staffordshire | England | British | 9070090003 | |||||
| WOODWARD, Lynn Carol | Geschäftsführer | 33 Cherry Orchard WS14 9AN Lichfield Staffordshire | England | British | 3850190004 | |||||
| WOODWARD, Lynn Carol | Geschäftsführer | 33 Cherry Orchard WS14 9AN Lichfield Staffordshire | England | British | 3850190004 | |||||
| YALOW, Elanna Sharon | Geschäftsführer | Holcomb Avenue Larkspur 427 California Ca94939 United States | Usa | United States | 138244770001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Hat BUSY BEES GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 21. Dez. 2010 Geliefert am 30. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 04. März 2010 Geliefert am 06. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and the related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 05. Juni 2009 Geliefert am 16. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Princess christian college wilbraham road fallowfields manchester. Chester street, aston lock south birmingham, land on the west side of manton lane bedford. For further properties please see form 395 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Mai 2005 Geliefert am 14. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholders or to the trustee (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 10. Juni 2004 Geliefert am 24. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1 (one) ordinary share of £1 issued by broomco (3347) limited (co no 4968447 together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 09. Juni 2004 Geliefert am 24. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 70,000 a ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees hroup limited (co no 3895685); 900 b ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685; 2 c ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 09. Juni 2004 Geliefert am 24. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 600,000 ordinary shares of £1.00 each issued by burntwood holdings limited )co no 03840104) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Juni 2004 Geliefert am 24. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0