CHADWICK HOMES LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHADWICK HOMES LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04969446
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHADWICK HOMES LTD?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich CHADWICK HOMES LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Greg`S Building 1
    Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHADWICK HOMES LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INVESTORS IN CARE LIMITED19. Nov. 200319. Nov. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHADWICK HOMES LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHADWICK HOMES LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Okt. 2022

    14 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Okt. 2021

    15 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 45 City Road Chester CH1 3AE zum Greg`S Building 1 Booth Street Manchester M2 4DU am 23. Nov. 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Okt. 2020

    LRESEX

    Vermögensübersicht

    10 SeitenLIQ02

    Beendigung der Bestellung von Deborah Grace Chadwick als Geschäftsführer am 30. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2018

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Deborah Grace Chadwick as a person with significant control on 20. Nov. 2018

    2 SeitenPSC01

    Notification of Jonathan Peter Chadwick as a person with significant control on 20. Nov. 2018

    2 SeitenPSC01

    Cessation of Jonathan Peter Chadwick as a person with significant control on 20. Nov. 2018

    1 SeitenPSC07

    Cessation of Deborah Grace Chadwick as a person with significant control on 20. Nov. 2018

    1 SeitenPSC07

    Eintragung der Belastung 049694460017, erstellt am 09. Nov. 2018

    22 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 049694460018, erstellt am 09. Nov. 2018

    23 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 049694460015 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 049694460016 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2017

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 049694460015, erstellt am 03. Mai 2017

    43 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 049694460016, erstellt am 03. Mai 2017

    35 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von CHADWICK HOMES LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHADWICK, Jonathan Peter
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    Sekretär
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    BritishDirector94561910001
    CHADWICK, Jonathan Peter
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector94561910001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    CHADWICK, Deborah Grace
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Reflections
    Fir Tree Lane
    RH20 2RA West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector94561930001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHADWICK HOMES LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Deborah Grace Chadwick
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    20. Nov. 2018
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Jonathan Peter Chadwick
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    20. Nov. 2018
    Fir Tree Lane
    West Chiltington
    RH20 2RA Pulborough
    Relections
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Jonathan Peter Chadwick
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    06. Apr. 2016
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mrs Deborah Grace Chadwick
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    06. Apr. 2016
    City Road
    CH1 3AE Chester
    45
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CHADWICK HOMES LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 09. Nov. 2018
    Geliefert am 13. Nov. 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    As a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, the mortgagor with full title guarantee charges to the lender a first legal mortgage over land at 1 ashurst avenue, saltdean, brighton, BN2 8DR, as registered under title ESX237267 and a first fixed charge. For more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Assetz Capital Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 09. Nov. 2018
    Geliefert am 13. Nov. 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    As a continuing security for the payment of the secured obligations, by way of first legal mortgage all properties owned by the company; and a fixed charge. For more details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Assetz Capital Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Mai 2017
    Geliefert am 09. Mai 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    1 orion houses, bruce avenue, worthing, BN11 5JN title no. WSX377567; 23 st andrews road, worthing, BN13 1HW title no. WSX169853.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Spf Bridging Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Mai 2017
    Geliefert am 09. Mai 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    1 orion houses, bruce avenue, worthing, BN11 5JN title no. WSX377567; 23 st andrews road, worthing, BN13 1HW title no. WSX169853.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Spf Bridging Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 31. März 2016
    Geliefert am 02. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land on the north side of bruce avenue, worthing, west sussex.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Apr. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 25. Nov. 2015
    Geliefert am 02. Dez. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    2 st andrews road burgess hill west sussex.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sallie Parker
    • Richard Parker
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 14. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Apr. 2014
    Geliefert am 10. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    2 st andrew road burgess hill west sussex t/n WSX56208.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juli 2012
    Geliefert am 27. Juli 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Windmill cottage old mill place pulborough west sussex. By way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 14. Juni 2012
    Geliefert am 16. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Mai 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juli 2010
    Geliefert am 24. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north east side of 32 culvers south harting petersfield west sussex t/no. WSX334781 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2008
    Geliefert am 04. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    99-101 high street, steyning, west sussex by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. März 2008
    Geliefert am 11. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    99-101 high street steyning t/no WSX309256 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2007
    Geliefert am 12. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at the rear of treetops hill farm lane codmore hill pulborough. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Jan. 2007
    Geliefert am 02. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land at the rear of laburnham cottage, hill farm lane, codmore hill, pulborough, west sussex t/no WSX300165. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Jan. 2007
    Geliefert am 02. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 42 high street, steyning t/no WSX257202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 23. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 23. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a the land at the rear of laburnham cottage hill farm lane codmore hill pulborough west sussex together with the dwelling house erected thereon k/a yew tree cottage t/no WSX114171. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 23. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 42 high street steyning t/no WSX257202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CHADWICK HOMES LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Okt. 2020Beginn der Liquidation
    04. Nov. 2023Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Mark Richardson
    Greg'S Building 1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Praktiker
    Greg'S Building 1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Edward Avery-Gee
    Cg & Co Gregs Building
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Praktiker
    Cg & Co Gregs Building
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0