VISUL HOMES UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVISUL HOMES UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04972563
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VISUL HOMES UK LIMITED?

    • (4521) /
    • (7011) /

    Wo befindet sich VISUL HOMES UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VISUL HOMES UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VISUAL HOMES UK LIMITED21. Nov. 200321. Nov. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VISUL HOMES UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für VISUL HOMES UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    16 SeitenWU15

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    20 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    19 SeitenWU07

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU zum 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB am 15. Nov. 2018

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    20 SeitenWU07

    Ernennung eines Liquidators

    3 SeitenWU04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Beeding Manor Pound Lane Upper Beeding Steyning West Sussex BN44 3JD zum C/O Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU am 26. Juni 2017

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 16. Aug. 2016

    12 Seiten1.3

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    14 SeitenCVA4

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 16. Aug. 2015

    12 Seiten1.3

    Ernennung von Rikki Hope als Sekretär am 20. Apr. 2014

    2 SeitenAP03

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 16. Aug. 2014

    12 Seiten1.3

    Ernennung von Kyle Oliver Hope als Direktor am 06. Apr. 2014

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Madeleine Joanne Lambert als Sekretär am 06. Apr. 2014

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Jeffrey Ernest Hope als Geschäftsführer am 06. Apr. 2014

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 16. Aug. 2013

    16 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 16. Aug. 2012

    14 Seiten1.3

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 13. Jan. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Aug. 2010

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Feb. 2010

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Aug. 2009

    2 Seiten3.6

    Wer sind die Geschäftsführer von VISUL HOMES UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOPE, Rikki
    Castle Lane
    BN44 3PB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    Sekretär
    Castle Lane
    BN44 3PB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    British193104770001
    HOPE, Kyle Oliver
    Castle Lane
    BN44 3FB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    England
    Geschäftsführer
    Castle Lane
    BN44 3FB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    England
    EnglandBritish190874780001
    HOPE, Jeffrey Ernest
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    Sekretär
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    British29203820002
    LAMBERT, Madeleine Joanne
    Beeding Manor
    Pound Lane Upper Beeding
    BN44 3JD Steyning
    West Sussex
    Sekretär
    Beeding Manor
    Pound Lane Upper Beeding
    BN44 3JD Steyning
    West Sussex
    British116755060001
    ROWBOTHAM, Brian
    23 Westlake Gardens
    BN13 1LF Worthing
    West Sussex
    Sekretär
    23 Westlake Gardens
    BN13 1LF Worthing
    West Sussex
    British5997360001
    THEYDON SECRETARIES LIMITED
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    Bevollmächtigter Sekretär
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    900011300001
    HOPE, Jeffrey Ernest
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    British29203820002
    MARSDEN, Neil Alexander Leslie
    1 Copperfields Close
    Kemsing
    TN15 6QW Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Copperfields Close
    Kemsing
    TN15 6QW Sevenoaks
    Kent
    British111810520001
    THEYDON NOMINEES LIMITED
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    900010330001

    Hat VISUL HOMES UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H unit 1 noble square industrial estate brynmawr south wales t/no wa 625727 together by way of first fixed charge all tools, equipment, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stewart James Davies
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H unit 1 noble square industrial estate brynmawr south wales t/no wa 625727 together by way of fixed charge the benefit of all deeds, agreement, contracts and warranties relating to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stewart James Davies
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Nov. 2006
    Geliefert am 14. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 1 noble square brynmawr gwent t/no. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2006
    Geliefert am 14. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 1 noble square brynmawr gwent t/no WA625727.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being unit 1 noble square industrial estate brynmawr blaenau gwent t/no WA625727 f/h property k/a or being fforchneol park (also k/a land at pantyfedwen) cwmaman aberdare t/no CYM2. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bridgebank Capital Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being land at fforchneol park (also k/a pantyfedwen) cwmamen aberdare t/no CYM273270. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bridgebank Capital Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 120. Jan. 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being unit 1 noble square industrial estate brynmawr blaenau gwent t/no WA625727. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bridgebank Capital Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 2006
    Geliefert am 04. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at pantyfedwen, cwmaman, aberdare t/n WA400530 fixed charge the benefit of all deeds agreements contracts and warranties, by way of assignment the goodwill and all the income together with the rights and remedies, all monies pursuant to all contracts or policies of insurance and the benefit of all licences and authorisations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stewart James Davies and Gene Melvin Laughton
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 1 noble square, brynmawr t/n WA625727 fixed charge the benefit of all deeds agreements contracts and warranties, by way of assignment the goodwill and all the income together with the rights and remedies, all monies pursuant to all contracts or policies of insurance and the benefit of all licences and authorisations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stewart James Davies and Gene Melvin Laughton
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 08. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 1 noble square, brynmawr t/n WA625727 and pantyfedwen, cwmaman, aberdare t/n WA400530. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stewart James Davies and Gene Melvin Laughton
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 06. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 1, noble square industrial estate, brynmawr, gwent t/n WA625727 including all buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • Visual Designs Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat VISUL HOMES UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gary Bell
    Cowgill Holloway
    49 Peter Street
    M2 3NG Manchester
    Receiver Manager
    Cowgill Holloway
    49 Peter Street
    M2 3NG Manchester
    2
    DatumTyp
    17. Aug. 2011Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    12. Apr. 2017Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Susan Agnes Maund
    White Maund Llp
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Praktiker
    White Maund Llp
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Andrew White
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Praktiker
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    3
    DatumTyp
    28. Sept. 2020Abschluss der Liquidation
    13. Feb. 2017Antragsdatum
    12. Apr. 2017Beginn der Liquidation
    08. März 2021Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Croydon
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Praktiker
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Ben Woolrych
    Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0