MONEYBOX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MONEYBOX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04978917 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MONEYBOX LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich MONEYBOX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CARDTRONICS UK LIMITED Building 4, 1st Floor Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Hertfordshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MONEYBOX LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NEWINCCO 324 LIMITED | 28. Nov. 2003 | 28. Nov. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONEYBOX LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MONEYBOX LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MONEYBOX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy David Kraft als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR am 16. Juni 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jeremy David Kraft als Direktor am 22. Sept. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Michael Keller als Sekretär am 07. Aug. 2013 | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von John Christopher Brewster als Direktor am 07. Aug. 2013 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Michael Keller als Direktor am 07. Aug. 2013 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2013 bis 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Davidson House Gadbrook Park Northwich Cheshire CW9 7TW am 12. Sept. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Simon Edwards als Geschäftsführer am 01. Sept. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brenda Mary Hogan als Sekretär am 07. Aug. 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael John Maloney als Geschäftsführer am 07. Aug. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MONEYBOX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLER, Michael Edward | Sekretär | c/o Cardtronics Uk Limited Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Building 4, 1st Floor Hertfordshire England | American | 105857220002 | ||||||
| BREWSTER, John Christopher | Geschäftsführer | c/o Cardtronics Uk Limited Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Building 4, 1st Floor Hertfordshire England | Usa | American | 181428100001 | |||||
| KELLER, Michael Edward | Geschäftsführer | c/o Cardtronics Uk Limited Trident Place Mosquito Way AL10 9UL Hatfield Building 4, 1st Floor Hertfordshire England | Usa | American | 105857220002 | |||||
| GREGSON, Robin Anthony | Sekretär | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | English | 107835250001 | ||||||
| HOGAN, Brenda Mary | Sekretär | Sandyford View Simonsridge Blackglen Road Sandyford Dublin 18 Apartment 55, Ireland | Other | 130814140001 | ||||||
| KATZ, Peter David | Sekretär | 20 Tudor Close IG8 0LF Woodford Green Essex | British | 64682050001 | ||||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Sekretär | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | British | 42734310002 | ||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||
| ABERNETHY, Kieron Quinn | Geschäftsführer | 2 Salisbury Place West Byfleet KT14 6SN London | United Kingdom | British | 200594530001 | |||||
| BEERLING, Kevin Michael | Geschäftsführer | 14 Firside Grove DA15 8WB Sidcup Kent | United Kingdom | British | 64677850002 | |||||
| BROWN, Neil Graeme | Geschäftsführer | 2 Aldenham Avenue WD7 8HJ Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 49772410001 | |||||
| EDWARDS, Mark Simon | Geschäftsführer | 2 Brook House Court Lakeside Road WA13 0GR Lymm Cheshire | British | 109659860001 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Geschäftsführer | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | 107835250001 | |||||
| ISAACS, Vincent | Geschäftsführer | 25 Mount View Close Hamstead Way NW3 London | British | 38705920002 | ||||||
| KRAFT, Jeremy David | Geschäftsführer | Avenue Gardens TW11 0BH Teddington 27 Middlesex England | United Kingdom | British | 71360190003 | |||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Geschäftsführer | 120 Buckingham Road SK4 4RG Stockport Cheshire | England | British | 42734310002 | |||||
| MALONEY, Michael John | Geschäftsführer | Beechwood Road Ranelagh 8 Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | 161364970001 | |||||
| MCNAMARA, Peter Denis | Geschäftsführer | 7 B Land Avenue AL5 4RG Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 114555600001 | |||||
| MILLS, Mark Richard | Geschäftsführer | 55 Hove Road FY8 1XH Lytham St Annes Lancashire | British | 10402540005 | ||||||
| MURPHY, James Timmerman | Geschäftsführer | Park Ave #10c Nyc 1120 10728 New York Usa | American | 130237490001 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Geschäftsführer | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | United Kingdom | British | 116252510001 | |||||
| SAXTON, Paul | Geschäftsführer | 19 Ashdale Close ST7 2EN Alsager Staffordshire | British | 121726830001 | ||||||
| SMYTH, Peter Francis | Geschäftsführer | Flat 2 62 Queens Gate SW7 5JP London | Irish | 63863190002 | ||||||
| STANLEY, Paul Robert | Geschäftsführer | 70 Wolmer Gardens HA8 8DQ Edgware Middlesex | British | 58251370003 | ||||||
| TURRELL, Mary Margaret | Geschäftsführer | 1 St Catherine Drive Hartford CW8 2FE Northwich Cheshire | England | British | 92654710001 | |||||
| OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Seventh Floor 90 High Holborn WC1V 6XX London | 900026670001 | |||||||
| OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 900026650001 |
Hat MONEYBOX LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A confirmatory security agreement | Erstellt am 09. Apr. 2010 Geliefert am 13. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 05. Dez. 2007 Geliefert am 15. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 06. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Syndicated debenture | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 06. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Juli 2005 Geliefert am 15. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by the company and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 2004 Geliefert am 09. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Sept. 2004 Geliefert am 03. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0