MONEYBOX LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMONEYBOX LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04978917
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MONEYBOX LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich MONEYBOX LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o CARDTRONICS UK LIMITED
    Building 4, 1st Floor Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Hertfordshire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MONEYBOX LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NEWINCCO 324 LIMITED28. Nov. 200328. Nov. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONEYBOX LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MONEYBOX LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MONEYBOX LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Jeremy David Kraft als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    12 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR am 16. Juni 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    1 SeitenAD04

    Ernennung von Mr Jeremy David Kraft als Direktor am 22. Sept. 2013

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Michael Keller als Sekretär am 07. Aug. 2013

    3 SeitenAP03

    Ernennung von John Christopher Brewster als Direktor am 07. Aug. 2013

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Michael Keller als Direktor am 07. Aug. 2013

    3 SeitenAP01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2013 bis 31. Dez. 2013

    1 SeitenAA01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Davidson House Gadbrook Park Northwich Cheshire CW9 7TW am 12. Sept. 2013

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Mark Simon Edwards als Geschäftsführer am 01. Sept. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Brenda Mary Hogan als Sekretär am 07. Aug. 2013

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Michael John Maloney als Geschäftsführer am 07. Aug. 2013

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MONEYBOX LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Sekretär
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    American105857220002
    BREWSTER, John Christopher
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican181428100001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican105857220002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Sekretär
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Sekretär
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Sekretär
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Sekretär
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Geschäftsführer
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Geschäftsführer
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    ISAACS, Vincent
    25 Mount View Close
    Hamstead Way
    NW3 London
    Geschäftsführer
    25 Mount View Close
    Hamstead Way
    NW3 London
    British38705920002
    KRAFT, Jeremy David
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    Geschäftsführer
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish71360190003
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Geschäftsführer
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Geschäftsführer
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Geschäftsführer
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    United KingdomBritish116252510001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Geschäftsführer
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001
    OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED
    Seventh Floor
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Seventh Floor
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    900026670001
    OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    900026650001

    Hat MONEYBOX LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A confirmatory security agreement
    Erstellt am 09. Apr. 2010
    Geliefert am 13. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 09. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security agreement
    Erstellt am 05. Dez. 2007
    Geliefert am 15. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Erstellt am 19. Dez. 2005
    Geliefert am 06. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Syndicated debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2005
    Geliefert am 06. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juli 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by the company and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Sept. 2004
    Geliefert am 09. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Sept. 2004
    Geliefert am 03. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0