MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04993066 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?
- Kreditvergabe durch Finanzierungsgesellschaften ohne Einlagen und andere spezialisierte Verbraucherkreditgeber (64921) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INHOCO 4024 LIMITED | 11. Dez. 2003 | 11. Dez. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB United Kingdom am 05. Okt. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Michelle Helen Elizabeth Pinggera am 01. Dez. 2011 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeff Stolz als Geschäftsführer am 23. Okt. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Gasvoda als Geschäftsführer am 01. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2011 | 16 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Highbridge Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1HR am 08. Apr. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirsten Pullan als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 22. Jan. 2010
| 2 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kevin Gasvoda am 08. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 17. Dez. 2009
| 2 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Okt. 2009
| 2 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Shaun Anthony, Mr. | Geschäftsführer | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | England | British | 163985940001 | |||||
| PINGGERA, Michelle Helen Elizabeth | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | England | British | 127185840001 | |||||
| PULLAN, Kirsten Alexandra | Sekretär | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | Other | 129462570001 | ||||||
| SPIELMANN, Karl Gordon | Sekretär | 6 Maxwell Road HP9 1QZ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 80702700002 | ||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| ARCHER, Foster | Geschäftsführer | Ramblers Highfield Road TW16 6DL Sunbury On Thames Middlesex | United Kingdom | Irish | 68207500001 | |||||
| BLUNDELL, Roger Frederick Crawford | Geschäftsführer | Vineyard Hill Road SW19 7JL London 61 | England | British | 56525730002 | |||||
| BRENNAN, Peter | Geschäftsführer | Nightingales Scotswood Close Penn Road HP9 2LJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 84912240002 | ||||||
| COLSELL, Steven James | Geschäftsführer | Limes House Bytham Road Ogbourne St George SN8 1TD Marlborough Wiltshire | England | British | 101387770001 | |||||
| DAVIES, Stephen | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | England | British | 66245130002 | |||||
| GASVODA, Kevin | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | Usa | Usa | 127186570001 | |||||
| GEORGE, Philip Anthony | Geschäftsführer | Ickenham Road Ruislip HA4 8BZ Middlesex 53 | United Kingdom | British | 131304410001 | |||||
| JOHNSON, David | Geschäftsführer | 12 The Witherings Emerson Park RM11 2RA Hornchurch Essex | British | 127119390001 | ||||||
| JONES, David Gareth | Geschäftsführer | Hillhouse Farm Misbrooks Green Road Beare Green RH5 4QQ Dorking Surrey | United Kingdom | British | 6205890002 | |||||
| KINGDON, Simon Charles | Geschäftsführer | Flint Meadow Hockley Lane Stoke Poges SL2 4QE Slough Berkshire | England | British | 56324870005 | |||||
| MALTBY, John Neil | Geschäftsführer | Priory House Priory Close BR7 5LB Chislehurst Kent | England | British | 84264890001 | |||||
| SANDERS, Colin George | Geschäftsführer | Tower Road Coleshill HP7 0LB Amersham Orchard House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | 131520530001 | |||||
| SPARKS, Daniel | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | British | 127187010001 | ||||||
| STOLZ, Jeff | Geschäftsführer | Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London | United Kingdom | British | 127186730001 | |||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Hat MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Erstellt am 23. Nov. 2007 Geliefert am 07. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge security document | Erstellt am 01. Aug. 2007 Geliefert am 17. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Part of first and second floor of keaton house, widewater place, moorhall road, harefield, uxbridge, middlesex and fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital and book debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 2006 Geliefert am 01. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First supplemental mortgage | Erstellt am 24. Feb. 2006 Geliefert am 25. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h interest in part first floor west part first floor east and part second floor storage and part second floor keaton house widewater place moorhall road harefield uxbridge middlesex,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 2005 Geliefert am 03. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 16. Juni 2004 Geliefert am 22. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h interest held by the chargor in the premises k/a (I) part first floor of keaton house, widewater place, moorhall road, harefield, uxbridge, middlesex; (ii) part second floor of keaton house, widewater place, moorhall road, harefield, uxbridge, middlesx; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0