REFINED PETROLEUM LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREFINED PETROLEUM LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04998448
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REFINED PETROLEUM LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich REFINED PETROLEUM LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REFINED PETROLEUM LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für REFINED PETROLEUM LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Dez. 2019 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Dr Simon Paul Lane am 31. Dez. 2018

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 30. Aug. 2019

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Change of details for Mrh (Gb) Limited as a person with significant control on 16. Juli 2019

    2 SeitenPSC05

    Ernennung von Thomas Mckenzie Biggart als Direktor am 11. März 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Pinsent Masons Secretarial Limited als Sekretär am 07. März 2019

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von David Hathaway als Sekretär am 07. März 2019

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Graham Paul Timbers als Geschäftsführer am 12. Feb. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Paul Lane als Direktor am 31. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr William Bahlsen Bannister als Direktor am 31. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH zum Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU am 02. Jan. 2019

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Steven John Back als Geschäftsführer am 15. Okt. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Graham Paul Timbers als Direktor am 12. Okt. 2018

    2 SeitenAP01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Karen Juanita Dickens als Geschäftsführer am 22. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Okt. 2017

    7 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2017 bis 30. Sept. 2017

    1 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von REFINED PETROLEUM LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Sekretär
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Sekretär
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    British117227730001
    KEATING, Roderick Charles
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Sekretär
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    British126363230002
    KEIDAN, Michael David Alan
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Sekretär
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Other1447490001
    QA REGISTRARS LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018500001
    BACK, Steven John
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    PEACOCK, Graham Frederick
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish5133310002
    PEARS, David Alan
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Geschäftsführer
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    EnglandBritish65200910001
    PEARS, Mark Andrew
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Geschäftsführer
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    EnglandBritish1447500008
    PEARS, Trevor Steven, Sir
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Geschäftsführer
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    EnglandBritish40036010005
    ROBINSON, Melvin Frank
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish146452070001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    EnglandBritish107002130001
    SHARPE, Steven
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    Geschäftsführer
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    EnglandBritish146452160001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish17957620003
    QA NOMINEES LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018490001
    WPG REGISTRARS LIMITED
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Geschäftsführer
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    106986280001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REFINED PETROLEUM LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrh (Gb) Limited
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer06360543
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat REFINED PETROLEUM LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Jubilee way service station high street lowestoft suffolk. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Redhouse service station middlemore lane aldridge walsall. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Roman road service station basingstoke road three mile cross reading. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Osprey service station wolverhampton road oldbury wayley. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Archway service station harlaxton road grantham lincolnshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Lobley hill service station lobley hill gateshead. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Homend service station homend ledbury herefordshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    St mary's service station nottingham road nottingham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Swallowfield service station woodcock lane berkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shell townend service station ridgeway road sheffield. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shell cambrian beatrice street oswestry. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Redcar service station trunk road redcar. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2005
    Geliefert am 26. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shepperton service station the high street shepperton. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 2004
    Geliefert am 06. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Queensland service station lower road belvedere in the london borough of bexley.
    Berechtigte Personen
    • Shell U.K. Limited
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0