INTERCITY GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINTERCITY GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05007870
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INTERCITY GROUP LIMITED?

    • Andere Reinigungsdienste (81299) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich INTERCITY GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ground Floor Suite River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INTERCITY GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    URBANDRIFT LIMITED06. Jan. 200406. Jan. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTERCITY GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für INTERCITY GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschlüsse

    Xfer of shares 01/03/2018
    RES13

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    8 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    8 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. März 2016

    Kapitalaufstellung am 09. März 2016

    • Kapital: GBP 522,653
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    7 SeitenAA

    Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Sekretär am 28. Sept. 2015

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Jonathan Stephen Levine als Direktor am 28. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Ian Saunders als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Saunders als Sekretär am 28. Sept. 2015

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Simon Kenneth Giles als Direktor am 09. März 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Scott Dudley als Geschäftsführer am 12. Feb. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 522,653
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 25. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 522,653
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Aeroworks Adair Street Manchester M1 2NQ* am 23. Aug. 2013

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von INTERCITY GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Sekretär
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    201342820001
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish196768780001
    LEVINE, Jonathan Stephen
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish19162600001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    British88908400002
    MCGIVERN, James Patrick
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    Sekretär
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    British120346770001
    SAUNDERS, Mark
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Sekretär
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    167235170001
    SCOBIE, James Martin
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    Sekretär
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    149533800001
    STRATFORD, Frederick
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Sekretär
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    162163700001
    DWF SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    C/O Dwf Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3AA Manchester
    Sekretär
    C/O Dwf Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3AA Manchester
    98868640001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOYLE, Eugene Daniel
    Teach Ban
    Parkside Drive
    PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Teach Ban
    Parkside Drive
    PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish86492920001
    BRADFORD, Richard James
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Geschäftsführer
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    United KingdomBritish72452740004
    CLEAVER, Simon Christopher
    42 Dunraven Road
    West Kirby
    CH48 4DU Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    42 Dunraven Road
    West Kirby
    CH48 4DU Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish101689040001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish88908400002
    DUDLEY, Scott
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish166551090001
    HARDY-WILSON, Nigel Andrew
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Geschäftsführer
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    EnglandBritish149590930001
    HOWROYD, David Rowan
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    British72333480002
    MCGIVERN, James Patrick
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    British120346770001
    PICKUP, James
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    British35926750001
    SALISBURY, Keith William
    Dingle House The Hampsons
    Off Belmont Road
    BL7 9QR Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dingle House The Hampsons
    Off Belmont Road
    BL7 9QR Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish100442000001
    SAUNDERS, Mark Ian
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish139588670003
    SCOBIE, James Martin
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    United KingdomBritish73982880001
    STRATFORD, Frederick Anthony
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Geschäftsführer
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    United KingdomBritish151871680001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INTERCITY GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Roger Leonard Burdett
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Simon Giles
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Jonathan Stephen Levine
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr David Mundell
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06. Apr. 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat INTERCITY GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 18. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Full title guarantee together with all money and bonuses. All options and rights policy no. LO192155203 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 05. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Capital Partners LLP
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 04. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 04. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Sept. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Juli 2007
    Geliefert am 17. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 11. Juli 2007
    Geliefert am 20. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Northwest Business Investment Scheme
    Transaktionen
    • 20. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2007
    Geliefert am 17. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Mai 2006
    Geliefert am 25. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Erstellt am 12. Jan. 2006
    Geliefert am 18. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policies being policy number 14/7602826-9 and all other monies due thereafter. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yfm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy being- insurer: halifax life, policy no: ASSH034011, life or lives assured: eugene boyle and stephen william dowe, sum assured: £667,000 payable on first death, term of cover: 5 years and commencement date: 18TH november 2005 and all monies, bonuses, profits, additions and benefits.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yfm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns the policies and all monies which shall become payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yfm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 20. Juli 2005
    Geliefert am 22. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The life policy and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it. The company's whole right title and interest present and future in the policy being insurer halifax life limited policy no. ASSH021538 lives assured eugene boyle and stephen dowe sum assured death benefit of £326,000.00 per person. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 12. Nov. 2004
    Geliefert am 24. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yfm Private Equity Limited
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Nov. 2004
    Geliefert am 16. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0