GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05009003 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Golden Square London W1F 9JG |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Jan. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Wright als Sekretär am 11. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2018 bis 26. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Jennifer Wright als Sekretär am 06. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emma Louise Greenfield als Sekretär am 06. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Nov. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Emma Louise Greenfield als Sekretär am 21. Juli 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Leonard Boyton als Geschäftsführer am 19. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sebastian James Speight als Geschäftsführer am 01. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Taylor Bugden als Geschäftsführer am 30. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2015 bis 30. Juni 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUICKSHANK, Sarah | Sekretär | 15 Golden Square London W1F 9JG | Other | 116598150001 | ||||||
FORSTER, Neil Andrew | Geschäftsführer | 15 Golden Square London W1F 9JG | United Kingdom | British | Finance Director | 138513740006 | ||||
REID, Duncan Murray | Geschäftsführer | 15 Golden Square London W1F 9JG | United Kingdom | British | 141322490001 | |||||
FORD, Susan Elizabeth | Sekretär | 48 Kempe Road Queens Park NW6 6SL London | British | 113724550001 | ||||||
GREENFIELD, Emma Louise | Sekretär | Golden Square W1F 9JG London 15 United Kingdom | 210705480001 | |||||||
PATEL, Ravi | Sekretär | Shortlands 19 Golf Side SM2 7HA South Cheam Surrey | British | Company Secretary | 66286440002 | |||||
WRIGHT, Jennifer | Sekretär | Golden Square W1F 9JG London 15 United Kingdom | 245302670001 | |||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
BOYTON, John Leonard | Geschäftsführer | 15 Golden Square London W1F 9JG | United Kingdom | British | 141319430001 | |||||
BUGDEN, Matthew Taylor | Geschäftsführer | 15 Golden Square London W1F 9JG | United Kingdom | British | Director | 138513720001 | ||||
CLAYTON, James Henry Michael | Geschäftsführer | 15 Golden Square London W1F 9JG | England | British | Director | 138513710001 | ||||
FORD, Susan Elizabeth | Geschäftsführer | 48 Kempe Road Queens Park NW6 6SL London | United Kingdom | British | Finance Director | 113724550001 | ||||
MCKENNA, Patrick Anthony | Geschäftsführer | Coxtie House Lincolns Lane Coxtie Green CM14 5RS Brentwood Essex | United Kingdom | British | Director | 69907480001 | ||||
MEAD, Kevin Thomas John | Geschäftsführer | 18 Gun Wharf 124 Wapping High Street E1W 2NJ London | England | British | Director | 81589600001 | ||||
PATEL, Ravi | Geschäftsführer | Shortlands 19 Golf Side SM2 7HA South Cheam Surrey | United Kingdom | British | Director | 66286440002 | ||||
SPEIGHT, Sebastian James | Geschäftsführer | Golden Square W1F 9JG London 15 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 138513700001 | ||||
COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingenious Media Limited | 01. Jan. 2017 | Golden Square W1F 9JG London 15 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat GALLIPOLI FILM PARTNER 2 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge over cash deposit and account and deed of assignment | Erstellt am 28. Juli 2005 Geliefert am 05. Aug. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit and the debts. Assigned all right title and interest in and to the benefit of the lease agreement and all right title and interest in and to the benefit of the guarantee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit and account and deed of assignment | Erstellt am 24. Juni 2005 Geliefert am 06. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The secured sums under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Charged the deposit being all monies or, as appropriate, any part thereof from time to time standing to the credit of the dedicated account being account number 360 3547 sort code 72-00-00 together with all entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing thereto or arising in connection therewith. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit and account and deed of assignment | Erstellt am 24. Juni 2005 Geliefert am 06. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The secured sums under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Charged the deposit being all monies or, as appropriate, any part thereof from time to time standing to the credit of the dedicated account being account number 360 3547 sort code 72-00-00 together with all entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing thereto or arising in connection therewith. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit and account and deed of assignment | Erstellt am 24. Juni 2005 Geliefert am 06. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The secured sums under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Charged the deposit being all monies or, as appropriate, any part thereof from time to time standing to the credit of the dedicated account being account number 360 3547 sort code 72-00-00 together with all entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing thereto or arising in connection therewith. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit and account and deed of assignment | Erstellt am 24. März 2005 Geliefert am 04. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge the deposit and the debts represented by the deposit,. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0