QMH FINANCE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | QMH FINANCE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05016653 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QMH FINANCE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich QMH FINANCE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Essex |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QMH FINANCE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
QUEENS MOAT HOUSES FINANCE LIMITED | 15. Jan. 2004 | 15. Jan. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QMH FINANCE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für QMH FINANCE LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für QMH FINANCE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Okt. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Queen Court 9-17 Eastern Road Romford RM1 3NG zum 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 29. Sept. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Martin Quinn als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Rosenberg als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Erwin Rieck als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Two Cv als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Britannia Llc als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Erwin Joseph Rieck am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von W2001 Two Cv als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von W2001 Britannia Llc als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Veronique Menard als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QMH FINANCE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUGHLAN, Sally Ann | Sekretär | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford 68 Essex England | British | 107832420001 | ||||||||||||
QUINN, Martin Joseph | Geschäftsführer | 34 Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | Asset Manager | 186571310001 | ||||||||||
CHRISTIAN, Tracy Joanne | Sekretär | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||||||||
PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||||
ALLSOP, Heather Louise | Geschäftsführer | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | Investment Banker | 101912850001 | |||||||||||
COLES, Alan Clifford | Geschäftsführer | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | Chartered Accountant | 101144900002 | ||||||||||
COLLYER, Brian Charles | Geschäftsführer | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | Investment Banker | 101144260001 | |||||||||||
GOIN, Russell Todd | Geschäftsführer | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | Banker | 108675490001 | |||||||||||
KABALAN, Fadi | Geschäftsführer | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | Chartered Accountant | 133846470001 | ||||||||||
KRAIS, Ashley Simon | Geschäftsführer | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | Company Director | 105921220001 | ||||||||||
MARSHALL, Steven | Geschäftsführer | Penton Lake Temple Gardens TW18 3NQ Staines Middlesex | British | Company Director | 94615400001 | |||||||||||
MENARD, Veronique Pascale Dominique | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | United Kingdom | French | Banker | 141156250001 | ||||||||||
METCALFE, Michael Stuart | Geschäftsführer | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Company Director | 40294180002 | ||||||||||
MOORE, Richard John | Geschäftsführer | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | Company Director | 101144680001 | ||||||||||
MULAHASANI, Heather Louise | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | Banker | 136994090001 | ||||||||||
OGDEN, Kathryn | Geschäftsführer | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | Analyst | 114248790002 | |||||||||||
RIECK, Erwin Joseph | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | Chief Executive Officer | 108675520002 | |||||||||||
ROSENBERG, Matthew Alexander | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | England | British | Asset Manager | 134723670001 | ||||||||||
W2001 BRITANNIA LLC | Geschäftsführer | The Corporation Trust Company 1209 Orange Street Wilmington The Corporation Trust Company County Of Newcastle Usa |
| 152068340001 | ||||||||||||
W2001 TWO CV | Geschäftsführer | Strawinskylaan 1207 1077 Xx Amsterdam Strawinskylaan 1207 Netherlands |
| 152068600001 |
Hat QMH FINANCE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Feb. 2005 Geliefert am 04. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 2004 Geliefert am 14. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. März 2004 Geliefert am 26. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A charge over deposits | Erstellt am 23. Jan. 2004 Geliefert am 28. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the each obligor to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0