BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05018017 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KAMAN COMPOSITES - UK HOLDINGS LIMITED | 20. Jan. 2011 | 20. Jan. 2011 |
| BROOKHOUSE HOLDINGS LIMITED | 13. Mai 2004 | 13. Mai 2004 |
| INHOCO 3035 LIMITED | 16. Jan. 2004 | 16. Jan. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 050180170004 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2020 bis 31. März 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Christopher John Morris als Direktor am 02. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Paul Rossiter als Direktor am 02. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Nord Aerospace Bidco Limited als Direktor am 02. Feb. 2021 | 3 Seiten | AP02 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 15 Seiten | MA | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 15 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Kennard Walsh als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Daniel Starr als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Lyon als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 050180170004, erstellt am 02. Feb. 2021 | 10 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Ian Kennard Walsh als Direktor am 01. Okt. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, Christopher John | Geschäftsführer | India Mill BB3 1AD Darwen India Mill Business Centre Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 279772890001 | |||||||||
| ROSSITER, Matthew Paul | Geschäftsführer | India Mill BB3 1AD Darwen India Mill Business Centre Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 279773100001 | |||||||||
| NORD AEROSPACE BIDCO LIMITED | Geschäftsführer | 74a Charlotte Street W1T 4QJ London Ariel House United Kingdom |
| 279785870001 | ||||||||||
| MCCAY, Michael | Sekretär | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | 150894090001 | |||||||||||
| THOMAS, Guy | Sekretär | Heathercombe Goodshaw Lane Crawshawbooth BB4 8DJ Rossendale Lancashire | British | 243854970002 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| BARNHART, Richard Roman | Geschäftsführer | Blue Hills Avenue 06002 Bloomfield 1332 Connecticut United States | United States | American | 238701340001 | |||||||||
| CLARK, Candace | Geschäftsführer | Waterville Road Avon Connecticut 290 06001 Usa | United States | 131481860001 | ||||||||||
| COLLIS, Michael Christopher | Geschäftsführer | 145 Holme Road NG2 5AG West Bridgford Nottinghamshire | England | British | 92105960001 | |||||||||
| DAWSON, Timothy Hugh | Geschäftsführer | St Leonards Close Harrogate HG2 8NU North Yorkshire 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 189597670001 | |||||||||
| DENNINGER, William C | Geschäftsführer | Roxbury Road 06902 Stamford 231 Conneticut Usa | Usa | Usa | 135136300001 | |||||||||
| GARNEAU, Robert Montgomery | Geschäftsführer | 47 Bittersweet Lane South Glastonbury Connecticut 06073 FOREIGN Usa | United States | 48031750001 | ||||||||||
| GLENNON, Andrew Paul | Geschäftsführer | 13 Broadway Tranmore Park Guiseley LS20 8JU Leeds Yorkshire | England | British | 84907350001 | |||||||||
| GODING, Joseph | Geschäftsführer | 1332 Blue Hills Avenue 06002 Bloomfield Kaman Corporation Connecticut Usa | Usa | American | 161182760001 | |||||||||
| KEATING, Neal | Geschäftsführer | Iselworth Country Cluc Drive Windermere 5057 Florida 34786 United States | United States | American | 131338140001 | |||||||||
| KENYON, Christopher | Geschäftsführer | Ladybridge Lane Heaton BL15DE Bolton Wayside United Kingdom | England | British | 189597660001 | |||||||||
| LAFLEUR, Michael Thomas | Geschäftsführer | India Mill BB3 1AD Darwen Kaman Composites Uk Ltd Lancashire United Kingdom | United States | American | 237419940001 | |||||||||
| LARWOOD, JR, James Carl | Geschäftsführer | 1332 Blue Hills Avenue 06002 Bloomfield Kaman Corporation Connecticut Usa | United States | American | 161182870001 | |||||||||
| LEES, Andrew John | Geschäftsführer | 4 Whitaker Green BB4 6RL Rawtenstall Lancashire | British | 97589290001 | ||||||||||
| LOCKWOOD, John B | Geschäftsführer | c/o Kaman Corporation Blue Hills Avenue 06002 Bloomfield 1332 Connecticut Usa | Usa | American | 161183060001 | |||||||||
| LYON, Michael James | Geschäftsführer | Blue Hills Avenue Bloomfield Ct 1332 Ct 06002 United States | United States | American | 166205910001 | |||||||||
| MCCAY, Michael John | Geschäftsführer | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | England | British | 27028700002 | |||||||||
| NEWTON, Paul Michael | Geschäftsführer | Over Hall Farm Flag Lane PR26 9AD Bretherton Lancashire | United Kingdom | British | 109730120001 | |||||||||
| NICHOLS, James | Geschäftsführer | 6 Balterley Court CW2 5SB Balterley Cheshire | England | British | 97001660002 | |||||||||
| RATCLIFFE, Jane Catherine | Geschäftsführer | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | United Kingdom | British | 139843980001 | |||||||||
| REMINGTON, Eric B | Geschäftsführer | River Boulevard Suffield 953 Connecticut 06001 United States | United States | 131337980001 | ||||||||||
| SMITH, Geoffrey Francis | Geschäftsführer | Churchend House Chatter Street Longney GL2 3SN Gloucester | England | British | 105381590001 | |||||||||
| STARR, Robert Daniel | Geschäftsführer | Blue Hills Avenue Bloomfield 06002 Connecticut 1332 United States | United States | American | 179471330001 | |||||||||
| STEINER, Gregory Lee | Geschäftsführer | 1332 Blue Hills Avenue Bloomfield Kaman Connecticut Usa | Usa | Usa | 131845020001 | |||||||||
| STIRLING, Colin Robert | Geschäftsführer | Oakfield Oak Road Cowthorpe LS22 5EY Wetherby West Yorkshire | England | British | 73958140001 | |||||||||
| THOMAS, Guy | Geschäftsführer | Heathercombe Goodshaw Lane Crawshawbooth BB4 8DJ Rossendale Lancashire | England | British | 243854970002 | |||||||||
| THORLEY, Ernest Richard | Geschäftsführer | 26 Eskdale Close Reedley BB10 2SH Burnley Lancashire | United Kingdom | British | 14230670002 | |||||||||
| TIPPER, Gary William | Geschäftsführer | 33 The Avenue Sale M33 4PJ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 125160140001 | |||||||||
| WALSH, Ian Kennard | Geschäftsführer | BB3 1AD Darwen India Mill Lancashire United Kingdom | United States | American | 275131710001 | |||||||||
| WHEELER, Carl Stephen | Geschäftsführer | India Mill India Mill Business Centre BB3 1AD Darwen Lancashire | United Kingdom | British | 148688200001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaman Uk Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | India Mill BB3 1AD Darwen India Mill Business Centre Lancashire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BROOKHOUSE COMPOSITES HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 02. Feb. 2021 Geliefert am 10. Feb. 2021 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2004 Geliefert am 20. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of keyman policy | Erstellt am 14. Apr. 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the policy with skandia assuring the life of james nichols,policy no CI1 014087616 with all bonuses,benefits and other monies thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0