WATERS EDGE LONDON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WATERS EDGE LONDON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05025844 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WATERS EDGE LONDON LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich WATERS EDGE LONDON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Evergreen House North Grafton Place NW1 2DX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WATERS EDGE LONDON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WATERS EDGE LONDON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER zum Evergreen House North Grafton Place London NW1 2DX am 24. Sept. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter William Murray am 02. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Change of details for Peter William Murray as a person with significant control on 02. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Change of details for Melanie Jayne Murray as a person with significant control on 02. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Melanie Jayne Murray am 02. Jan. 2018 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Melanie Jayne Murray am 02. Jan. 2018 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Change of details for Melanie Jayne Murray as a person with significant control on 02. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter William Murray am 02. Dez. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WATERS EDGE LONDON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY, Melanie Jayne | Sekretär | 11/15 William Road NW1 3ER London Acre House United Kingdom | British | 84666930001 | ||||||
| MURRAY, Peter William | Geschäftsführer | 11/15 William Road NW1 3ER London Acre House United Kingdom | United Kingdom | British | 78642090004 | |||||
| LAWSON (LONDON) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Acre House 11-15 William Road NW1 3ER London | 900018120001 | |||||||
| ACRE (CORPORATE DIRECTOR) LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Acre House 11-15 William Road NW1 3ER London | 900021510001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WATERS EDGE LONDON LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Melanie Jayne Murray | 06. Apr. 2016 | 11/15 William Road NW1 3ER London Acre House United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Peter William Murray | 06. Apr. 2016 | 11/15 William Road NW1 3ER London Acre House United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat WATERS EDGE LONDON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Erstellt am 14. Juli 2008 Geliefert am 18. Juli 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Flat 13, atlantic house A5 beaufort park hendon london fixed charge all fixtures fittings plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the property floating charge all other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which are from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Juli 2008 Geliefert am 18. Juli 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Flat 39, 1 tarves way greenwich london fixed charge all fixtures fittings plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the property floating charge all other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which are from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Juni 2004 Geliefert am 10. Juni 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 26 longstone court, 22 great dover street, london,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Mai 2004 Geliefert am 26. Mai 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Apartment 112 salamanca square albert embankment london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Apr. 2004 Geliefert am 26. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property known as 11 courtyard apartments 59 st. Mary church street london t/g TGL230937. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over a cash deposit | Erstellt am 06. Apr. 2004 Geliefert am 20. Apr. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The charged account of the company with the bank of scotland as defined in clause 13.1 of the charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Apr. 2004 Geliefert am 08. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WATERS EDGE LONDON LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0