GREENLIT RIGHTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREENLIT RIGHTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05043446
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREENLIT RIGHTS LIMITED?

    • (9211) /

    Wo befindet sich GREENLIT RIGHTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREENLIT RIGHTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREENLIT RIGHTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Aug. 2011

    8 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Feb. 2011

    8 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    21 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor Garfield House 86-88 Edgware Road London W2 2EA am 25. Aug. 2010

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    21 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    5 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung und/oder der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Feb. 2010

    Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Robert Kirby als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Anthony Horowitz als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    11 Seiten395

    legacy

    2 Seiten288a

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    10 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Inter-company guarantee 15/02/2008
    RES13

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von GREENLIT RIGHTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GREEN, Jill Rosemary
    Sabian House
    26-27 Cowcross Street
    EC1M 6DQ London
    Geschäftsführer
    Sabian House
    26-27 Cowcross Street
    EC1M 6DQ London
    EnglandBritish59670990002
    RAYSON, Alison Dawn
    17 Creek Road
    KT8 9BE East Moslesey
    Kings House
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 Creek Road
    KT8 9BE East Moslesey
    Kings House
    Surrey
    Great BritainBritish139392710001
    GREEN, Jill Rosemary
    Sabian House
    26-27 Cowcross Street
    EC1M 6DQ London
    Sekretär
    Sabian House
    26-27 Cowcross Street
    EC1M 6DQ London
    British59670990002
    GUTIERREZ, Eve Louise
    24 Herne Hill House
    Railton Road
    SE24 0EE London
    Sekretär
    24 Herne Hill House
    Railton Road
    SE24 0EE London
    British86100240001
    KIRBY, Robert Henry
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    Sekretär
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    British131528280001
    THOM, Alastair Stephen
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    Sekretär
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    British9591260001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    HOROWITZ, Anthony John
    Sabian House
    26-27 Cowcross Street
    EC1M 6DQ London
    Geschäftsführer
    Sabian House
    26-27 Cowcross Street
    EC1M 6DQ London
    United KingdomBritish11506040002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat GREENLIT RIGHTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 04. Apr. 2008
    Geliefert am 17. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the company's right in the programme or series of television programmes entitled caught in a trap, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 2008
    Geliefert am 27. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Dez. 2007
    Geliefert am 20. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £13,812.50 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    A designated interest earning deposit account opened with bank of ireland in the name of tnw solicitors re maxine bourne sarah jane phillips and deborah bourne acct no 74423700.
    Berechtigte Personen
    • Maxine Bourne Sarah Jane Phillips and Deborah Bourne
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over television programme provisionally entitled "honest" (pka "outrageous fortunes")
    Erstellt am 24. Apr. 2007
    Geliefert am 26. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Copyright, the series of programmes including soundtrack all videotape audiotape and preprint elements screenplays all property contracts distribution agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over the television programme entitled 'head cases'
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 09. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title and interest in and to the programme including the soundtrack thereof entitled 'headcases'. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 31. Jan. 2007
    Geliefert am 07. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in and to the programme or the series of television programmes entitled "foyle's war - series 6" the rights in respect of the programme any agreement the proceeds of all policies of insurance now and/or all sums from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit and account
    Erstellt am 27. Jan. 2005
    Geliefert am 02. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partners (the "borrowers") for the time being of crystal film partners acting in its capacity as lessor (the "lessor") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of deposit and charge on cash deposit
    Erstellt am 27. Jan. 2005
    Geliefert am 31. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All sums from time to time standing to the credit of a deposit account (number 77096CR). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on deposits
    Erstellt am 27. Jan. 2005
    Geliefert am 01. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £3,804,265.69 deposited in the depositor's gbp account (account no. 4.01.40.148) in respect of the lease agreement relating to the film entitled " foyle's war" and all present and future right, title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 24. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The company's right title and interest in and to the programme. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 14. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest in the depost (£11,688) relating to 3RD loor,14/15 darblay st,london W1.
    Berechtigte Personen
    • Maxine Bourne,Sarah Jane Phllips and Deborah Bourne
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 04. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £11,688 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The companys interst in a designated interest bearing deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Maxine Bourne
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 22. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 28. Feb. 2008
    Deed of deposit and charge on cash deposit
    Erstellt am 01. Okt. 2004
    Geliefert am 20. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All sums standing to the credit of an interest bearing sterling deposit account (number 72428) of greenlit rights limited with abbey national treasury services PLC, and all entitlements to interest and other rights from time to time accuring to or arising in connection with such sums, and the debt represented thereby.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GREENLIT RIGHTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Aug. 2010Beginn der Verwaltung
    12. Aug. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Andrew Howard Beckingham
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0