KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED

KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusVerwalter bestellt
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05044674
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Fairfax House 6a Mill Field Road
    Cottingley
    BD16 1PY Bingley
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. März 2017
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Dez. 2017
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis15. Feb. 2018
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung01. März 2018
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis15. Feb. 2017
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Hawkcliffe Works Hebden Road Oxenhope West Yorkshire BD22 9SY zum Fairfax House 6a Mill Field Road Cottingley Bingley BD16 1PY am 23. Aug. 2023

    1 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2022

    3 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2022

    3 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2022

    3 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2021

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2021

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2021

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2021

    3 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2021

    3 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2020

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2019

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2019

    5 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2019

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2019

    5 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2020

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2019

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2019

    5 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2021

    3 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2020

    6 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Feb. 2020

    4 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2018

    5 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2018

    5 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2018

    5 SeitenREC2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2017

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Aug. 2017

    2 Seiten3.6

    Wer sind die Geschäftsführer von KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KELLY, Mark Anthony
    5 Church Court
    Riddlesden
    BD20 5PG Keighley
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Church Court
    Riddlesden
    BD20 5PG Keighley
    West Yorkshire
    British84328510001
    CLOUGH, Andrew
    44 Roedhelm Road
    BD20 5RF East Morton
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    44 Roedhelm Road
    BD20 5RF East Morton
    West Yorkshire
    United KingdomBritish84328470003
    KELLY, Mark Anthony
    5 Church Court
    Riddlesden
    BD20 5PG Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Church Court
    Riddlesden
    BD20 5PG Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritish84328510001
    WOGDEN, Mark Ashley
    79 Skipton Road
    Silsden
    BD20 9DA Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    79 Skipton Road
    Silsden
    BD20 9DA Keighley
    West Yorkshire
    EnglandCanadian45770350001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    KELLY, Julie Anne
    5 Church Court
    Riddlesden
    BD20 5PG Keighley
    Sekretär
    5 Church Court
    Riddlesden
    BD20 5PG Keighley
    British48059340003
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Mark Anthony Kelly
    6a Mill Field Road
    Cottingley
    BD16 1PY Bingley
    Fairfax House
    England
    15. Feb. 2017
    6a Mill Field Road
    Cottingley
    BD16 1PY Bingley
    Fairfax House
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mr Mark Ashley Wogden
    6a Mill Field Road
    Cottingley
    BD16 1PY Bingley
    Fairfax House
    England
    15. Feb. 2017
    6a Mill Field Road
    Cottingley
    BD16 1PY Bingley
    Fairfax House
    England
    Nein
    Nationalität: Canadian
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mr Andrew Clough
    6a Mill Field Road
    Cottingley
    BD16 1PY Bingley
    Fairfax House
    England
    15. Feb. 2017
    6a Mill Field Road
    Cottingley
    BD16 1PY Bingley
    Fairfax House
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2008
    Geliefert am 03. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Park house the green bingley west yorkshire; assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 309. Aug. 2016Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 3
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 2007
    Geliefert am 19. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at church road horsforth leeds t/no WYK276947. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 109. Aug. 2016Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 1
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Juli 2007
    Geliefert am 04. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Park house the green college road bingley west yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Mai 2007
    Geliefert am 12. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hawcliffe works hebden road keighley west yorkshire,. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 12. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 209. Aug. 2016Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 2
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Dez. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at church road horsforth leeds. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Sept. 2004
    Geliefert am 25. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at aire view silsden keighley. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juli 2004
    Geliefert am 10. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 10. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat KELLY DEVELOPMENTS (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Receiver Manager
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Receiver Manager
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Receiver Manager
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Receiver Manager
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Receiver Manager
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Receiver Manager
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0