CBRAIL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CBRAIL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05050256 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CBRAIL LIMITED?
- Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CBRAIL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CBRAIL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CBRAIL LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CBRAIL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom zum Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB zum 1 More London Place London SE1 2AF am 19. Dez. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Lloyds Secretaries Limited als Sekretär am 13. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin White als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil Dewar Lewis am 23. Jan. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Graham Dowsett als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Durham als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Dewar Lewis als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Gavin White am 07. März 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CBRAIL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| DOWSETT, Colin Graham | Geschäftsführer | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 United Kingdom | England | British | 152332230001 | |||||||||
| LEWIS, Neil Dewar | Geschäftsführer | 10 Old Burlington Street W1S 3AG London C/O Lw2 United Kingdom | England | British | 103229440001 | |||||||||
| DOWNS, Steven George | Sekretär | Scarecrows 66 Leas Road CR6 9LL Warlingham Surrey | British | 16641880002 | ||||||||||
| GITTINS, Paul | Sekretär | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | British | 45660860003 | ||||||||||
| LODGE, Matthew Sebastian | Sekretär | Rose Cottage Dog Lane Stainland HX4 9QF Halifax West Yorkshire | British | 32609030001 | ||||||||||
| WHITE, Gavin Raymond | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 165229200001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| DAVY, Philip Maturin | Geschäftsführer | Fair Meadow Broxmead Lane RH17 5JH Cuckfield West Sussex | England | British | 96202910001 | |||||||||
| DAVY, Philip Maturin | Geschäftsführer | Fair Meadow Broxmead Lane RH17 5JH Cuckfield West Sussex | England | British | 96202910001 | |||||||||
| DUNCAN, Timothy | Geschäftsführer | Ellerslie House The Glade KT20 6LL Kingswood Surrey | United Kingdom | British | 104005710001 | |||||||||
| DURHAM, Timothy Sebastian | Geschäftsführer | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | British | 152682880001 | |||||||||
| GOOSEN, Willem | Geschäftsführer | Vogelsangstrasse 6 Grunwald 82031 Germany | Dutch | 104881570002 | ||||||||||
| LEWIS, Neil Dewar | Geschäftsführer | 15th Floor 5 Aldermanbury Square EC2V 7HR London Babcock & Brown International Group | England | British | 103229440001 | |||||||||
| MARR, Graham Peter Wilson | Geschäftsführer | Mole Rise 15 Harebell Hill KT11 2RS Cobham Surrey | England | British | 69564800002 | |||||||||
| MORE, Gordon Lennie Truman | Geschäftsführer | 20 Dollarbeg Park FK14 7LJ Dollar Clackmannanshire | United Kingdom | Scottish | 111414890002 | |||||||||
| MORRISSEY, John Michael | Geschäftsführer | 66 Selborne Road Southgate N14 7DG London | England | British | 94094650001 | |||||||||
| PETERS, Stephen John | Geschäftsführer | Old Swan Cottage 9 London Road TN16 1BB Westerham Kent | British | 56296720007 | ||||||||||
| PETERS, Stephen John | Geschäftsführer | Old Swan Cottage 9 London Road TN16 1BB Westerham Kent | British | 56296720007 | ||||||||||
| REID, George Gibson | Geschäftsführer | 46/1 Morningside Park EH10 5HA Edinburgh Lothian | British | 95498730001 | ||||||||||
| SHINDLER, David Lawrence | Geschäftsführer | 4 Berkeley Close WD6 3JN Elstree Hertfordshire | British | 92235400001 | ||||||||||
| SHINDLER, David Lawrence | Geschäftsführer | 4 Berkeley Close WD6 3JN Elstree Hertfordshire | British | 92235400001 | ||||||||||
| TOWN, Lindsay John | Geschäftsführer | 10 Ferndale TN2 3PB Tunbridge Wells Kent | England | British | 64287260001 | |||||||||
| WALSH, Kenton | Geschäftsführer | Winter House 83 Hedgerley Lane HP9 2JS Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 125918020001 | |||||||||
| WILSON, Edward Arthur | Geschäftsführer | Flat 3 28 Folgate Street E1 6BX London | United Kingdom | British | 214718430001 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat CBRAIL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Erstellt am 07. Apr. 2006 Geliefert am 26. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge in and to all of the secured property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 29. März 2006 Geliefert am 06. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the shares and all stock shares warrents securities rights moneys and property (including the dividends interest or income thereon or wherefrom). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge over shares | Erstellt am 21. Dez. 2005 Geliefert am 23. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from cbrail (nordarz) limited to the bank or the chargee on any accountw hatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest in and to the shares and all stock shares warrants securities rights moneys or property (including dividends interest or income). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 27. Okt. 2005 Geliefert am 07. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from cbrail (ruhr-sieg) limited to the chargee or the bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights, title and interest in and to the shares (including the dividends). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 13. Jan. 2005 Geliefert am 28. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge over shares | Erstellt am 12. Nov. 2004 Geliefert am 19. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CBRAIL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0