VORAMEX LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVORAMEX LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05056089
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VORAMEX LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich VORAMEX LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o MOORE STEPHENS LLP
    Third Floor
    1 Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VORAMEX LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VORAMEX LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für VORAMEX LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Mai 2015

    16 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    8 Seiten2.39B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Feb. 2015

    14 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    18 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6Th Floor, Nr 1 Redcliff Street Bristol BS1 6NP England zum C/O Moore Stephens Llp Third Floor 1 Redcliff Street Bristol BS1 6NP am 20. Aug. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Eintragung der Belastung 050560890009

    9 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 050560890010

    9 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 050560890015

    9 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 050560890011

    9 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 050560890016

    9 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 050560890012

    9 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 050560890014

    9 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 050560890013

    9 SeitenMR01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Mai 2013 bis 30. Juni 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2012

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Apr. 2013

    Kapitalaufstellung am 17. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2011

    9 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Wer sind die Geschäftsführer von VORAMEX LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NIGHTINGALE, Steven
    c/o Moore Stephens Llp
    1 Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Third Floor
    Sekretär
    c/o Moore Stephens Llp
    1 Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Third Floor
    British95817730002
    CLARKE, Richard Anthony
    c/o Moore Stephens Llp
    1 Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Third Floor
    Geschäftsführer
    c/o Moore Stephens Llp
    1 Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Third Floor
    United KingdomBritish118861960002
    NIGHTINGALE, Steven
    c/o Moore Stephens Llp
    1 Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Third Floor
    Geschäftsführer
    c/o Moore Stephens Llp
    1 Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Third Floor
    United KingdomBritish95817730002
    COURTIER-DUTTON, David Anthony
    Little Park House
    Brimpton
    RG7 4ST Reading
    Sekretär
    Little Park House
    Brimpton
    RG7 4ST Reading
    British67122510004
    MACDONALD, Angus Crawford
    The Barn House
    Parbrook
    BA6 8PD Glastonbury
    Somerset
    Sekretär
    The Barn House
    Parbrook
    BA6 8PD Glastonbury
    Somerset
    British84324490002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    COURTIER-DUTTON, David Anthony
    Little Park House
    Brimpton
    RG7 4ST Reading
    Geschäftsführer
    Little Park House
    Brimpton
    RG7 4ST Reading
    United KingdomBritish67122510004
    FIRMSTONE, Francis
    75 Wakehurst Road
    Battersea
    SW11 6DA London
    Geschäftsführer
    75 Wakehurst Road
    Battersea
    SW11 6DA London
    British90092600001
    HODGES, Jonathan Scrimgeour
    291 Monaco Street
    Broadbeach Waters
    FOREIGN Qld 4218 Australia
    Geschäftsführer
    291 Monaco Street
    Broadbeach Waters
    FOREIGN Qld 4218 Australia
    British97823120002
    MACDONALD, Angus Crawford
    The Barn House
    Parbrook
    BA6 8PD Glastonbury
    Somerset
    Geschäftsführer
    The Barn House
    Parbrook
    BA6 8PD Glastonbury
    Somerset
    British84324490002
    O'BRIEN, Craig Stuart
    12 Luccombe Hill
    Redland
    BS6 6SN Bristol
    Geschäftsführer
    12 Luccombe Hill
    Redland
    BS6 6SN Bristol
    United KingdomBritish95817750001
    PRICE, Stephen Philip
    Ferney Hill
    Ferney
    GL11 5AB Dursley
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Ferney Hill
    Ferney
    GL11 5AB Dursley
    Gloucestershire
    EnglandBritish68971250001
    STOREY, Stephen Brian
    Churnmead Farm,
    Kington Road
    BS35 1PJ Thornbury Bristol
    Geschäftsführer
    Churnmead Farm,
    Kington Road
    BS35 1PJ Thornbury Bristol
    EnglandEnglish85470520001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat VORAMEX LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 7066 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 6010 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 6008 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 6003 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 5010 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 2014 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 1010 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Flat 1003 the robinson building bedminster bristol.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal charge
    Erstellt am 04. März 2008
    Geliefert am 11. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    East street baptist church east street bedminster bristol t/no BL96155 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Okt. 2007
    Geliefert am 10. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at norfolk place bedminster bristol and 157 and 159 east street bedminster bristol. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. Okt. 2007
    Geliefert am 10. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at norfolk place, bedminster (k/a the robinson's building) together with 157 and 159 east street, bedminster. T/nos bl 38073, BL37358, AV2597 and BL39899 by way of fixed charge the goodwill and all plant machinery implements utensils equipment and furniture.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 2005
    Geliefert am 21. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    157 and 159 east street bedminster bristol. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 2004
    Geliefert am 04. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings at norfolk place bedminster t/no's BL39899 and BL38073. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2004
    Geliefert am 04. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H properties registered under t/no's B. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat VORAMEX LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Aug. 2014Beginn der Verwaltung
    12. Mai 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Miles Needham
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Stephen Anthony John Ramsbottom
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Avon
    Praktiker
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Avon
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    DatumTyp
    12. Mai 2015Beginn der Liquidation
    06. Juli 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Stephen Anthony John Ramsbottom
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Avon
    Vorgeschlagener Liquidator
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Avon
    Stephen Anthony John Ramsbottom
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Avon
    Praktiker
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Avon
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0