AUXILIA GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAUXILIA GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05067413
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AUXILIA GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich AUXILIA GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AUXILIA GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AUXILIA HOLDINGS LIMITED21. Mai 200421. Mai 2004
    ETCHCO 1229 LIMITED09. März 200409. März 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AUXILIA GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für AUXILIA GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Juli 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Jan. 2010

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 2 Cornwall Street Birmingham West Midlands B3 2DL am 22. Dez. 2009

    1 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Juli 2009

    7 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Jan. 2009

    15 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Geänderte Bescheinigung über die Zusammensetzung des Gläubigerausschusses

    1 Seiten2.26B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    20 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    4 Seiten2.23B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    41 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    7 Seiten395

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    34 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten88(2)R

    legacy

    2 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04

    Wer sind die Geschäftsführer von AUXILIA GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PRICE, Andrew David
    5 Edwin Close
    ST17 9XN Stafford
    Staffs
    Sekretär
    5 Edwin Close
    ST17 9XN Stafford
    Staffs
    British91322820003
    JOHNSON, Keith
    Totterton Hall
    SY7 8AN Totterton
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Totterton Hall
    SY7 8AN Totterton
    Shropshire
    British97190190001
    MUNCASTER, Paul
    Apt. 8 Lawton Hall
    Lawton Hall Drive, Church Lawton
    ST7 3ET Stoke On Trent
    Geschäftsführer
    Apt. 8 Lawton Hall
    Lawton Hall Drive, Church Lawton
    ST7 3ET Stoke On Trent
    EnglandBritish99518690004
    PRICE, Andrew David
    5 Edwin Close
    ST17 9XN Stafford
    Staffs
    Geschäftsführer
    5 Edwin Close
    ST17 9XN Stafford
    Staffs
    EnglandBritish91322820003
    JOHNSON, Keith
    Totterton Hall
    SY7 8AN Totterton
    Shropshire
    Sekretär
    Totterton Hall
    SY7 8AN Totterton
    Shropshire
    British97190190001
    ETCHCO (NUMBER 6) LIMITED
    39 Newhall Street
    B3 3DY Birmingham
    Sekretär
    39 Newhall Street
    B3 3DY Birmingham
    52631720001
    SEAGER, Kevin George
    38 Kilmorie Road
    WS11 1HZ Cannock
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    38 Kilmorie Road
    WS11 1HZ Cannock
    Staffordshire
    British12629340001
    EFFECTORDER LIMITED
    39 Newhall Street
    B3 3DY Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    39 Newhall Street
    B3 3DY Birmingham
    West Midlands
    52631710001

    Hat AUXILIA GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2007
    Geliefert am 24. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 29 brow lane shelf halifax t/no WYK547748. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juli 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery, the mortgaged chattels, the goodwill and the uncalled capital all copyrights patents trademarks and all other intellectual property rights, the book debts and other debts, the stock in trade work in progress and all other undertakings and all other property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Alan Muncaster and Jennifer Ann Muncaster
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 29. Juli 2004
    Geliefert am 03. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge 1,000 ordinary shares of £1 each in the share capital of peak refrigeration limited (securities) and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. Apr. 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over shares
    Erstellt am 07. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge 55,000 ordinary shares of £1 each issued to the company by etchco 1227 limited (securities) and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions all accreditations rights benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat AUXILIA GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juli 2007Beginn der Verwaltung
    11. Juli 2008Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    2
    DatumTyp
    11. Juli 2008Beginn der Liquidation
    12. Juli 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard James Philpott
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0