RATIH MARITIME LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRATIH MARITIME LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05068426
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RATIH MARITIME LIMITED?

    • See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich RATIH MARITIME LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Finsbury Circus
    EC2M 7SH London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RATIH MARITIME LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RATIH MARITIME LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für RATIH MARITIME LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. März 2014

    Kapitalaufstellung am 12. März 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Robert Fyfe Speedie als Geschäftsführer am 20. Sept. 2011

    2 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom One St. Paul's Churchyard London EC4M 8SH am 12. Apr. 2011

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Cornhill Secretaries Limited am 09. Apr. 2010

    2 SeitenCH04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Sekretärs für Cornhill Secretaries Limited am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Siana Anggraeni Surya am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von RATIH MARITIME LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CORNHILL SECRETARIES LIMITED
    Baden Place
    Crosby Row
    SE1 1YW London
    8
    United Kingdom
    Bevollmächtigter Sekretär
    Baden Place
    Crosby Row
    SE1 1YW London
    8
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer461605
    900023430001
    CANNON, Alexander
    4 Kilkerran Park
    Newton Mearns
    G77 6ZS Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    4 Kilkerran Park
    Newton Mearns
    G77 6ZS Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish22450002
    SURYA, Siana Anggraeni
    Cairnhill Road
    #06-11
    229668 Singapore
    57
    Singapore
    Geschäftsführer
    Cairnhill Road
    #06-11
    229668 Singapore
    57
    Singapore
    SingaporeIndonesian135861900005
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Sekretär
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Other95892040003
    CARON DELION, Patrick
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    Sekretär
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    British95892040001
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Sekretär
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    BRIGHTON SECRETARY LTD
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    Bevollmächtigter Sekretär
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    900023320001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Geschäftsführer
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOther95892040003
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Geschäftsführer
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritish72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Geschäftsführer
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritish83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Geschäftsführer
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritish99475270002
    SPEEDIE, Robert Fyfe
    57 Dunellan Road
    Milngavie
    G62 7RE Glasgow
    Geschäftsführer
    57 Dunellan Road
    Milngavie
    G62 7RE Glasgow
    United KingdomBritish95452710001
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Geschäftsführer
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    British72665990003
    BRIGHTON DIRECTOR LTD
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    900023310001

    Hat RATIH MARITIME LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Proceeds deposit account agreement
    Erstellt am 12. Nov. 2008
    Geliefert am 17. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the proceeds deposit account having sort code 30-00-02 account number 00741707 and the moneys interest and amounts on such account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority statutory singapore ship mortgage
    Erstellt am 06. Mai 2004
    Geliefert am 17. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel registered in the ownership of the owner under the flag of singapore with o/no 390663 together with her boats, guns, ammunition, small arms and appurtenances.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pt Berlian Laju Tanker Tbk
    Transaktionen
    • 17. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Mai 2004
    Geliefert am 14. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the singapore registered ship "ratih" with official number 390663 and in her boats guns ammunition small arms and appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No 12) Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A first priority singapore ship mortgage
    Erstellt am 06. Mai 2004
    Geliefert am 12. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the security parties to the assignee and the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All sixty-four sixty-fourth shares in the vessel and in her boats guns ammunition small arms and appurtenances, chemical tanker M.T. 'oriental lily' singapore flag and to be renamed 'raith'. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, Singapore Branch
    Transaktionen
    • 12. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Second priority deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 06. Apr. 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's right, title and interest, present and future, in and to (a) the earnings of the panamanian registered chemical tanker named "oriental lily" and to be registered on the singapore ship register renamed "ratih" (the vessel) (b) all policies and contracts of insurance and/or reinsurance which are from time to time in place, taken out or entered into. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No. 12) Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority deed of assignment of insurances relating to "oriental lily"
    Erstellt am 06. Apr. 2004
    Geliefert am 23. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from allco UK to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Each assignor assigns with full title guarantee being all of the right, title and interest, present and future of an assignor in, to and under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pt Berlian Laju Tanker Tbk
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the security parties to the security trustee or the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole of the company's undertaking property and assets whatsoever and wheresoever both at the time of the deed and in the future including and uncalled capital and the proceeds of any future calls.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Norsdbank Ag, Singapore Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 06. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the security parties to the assignee and the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest in to and under the earnings and insurances, any requisition compensation, each account and all sums of money, the charterparty and the guarantee of charter, the charterer's assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, Singapore Branch
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0