LOWELL FINANCE LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLOWELL FINANCE LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05069513
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LOWELL FINANCE LTD?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich LOWELL FINANCE LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LOWELL FINANCE LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KYTE HOLDINGS 2 LIMITED10. Mai 200410. Mai 2004
    PRECIS (2411) LIMITED10. März 200410. März 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOWELL FINANCE LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für LOWELL FINANCE LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 16. Feb. 2022

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Dez. 2021

    15 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 05. Sept. 2021

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 02. Juli 2021

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Dez. 2020

    20 SeitenLIQ03

    Zweite Einreichung der Bestätigungserklärung vom 30. März 2020

    3 SeitenRP04CS01

    Beendigung der Bestellung von Bill Flynn als Sekretär am 30. Apr. 2020

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. März 2020 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    25. Sept. 2020Clarification A SECOND FILED CS01 STATEMENT OF CAPITAL & SHAREHOLDER INFORMATION WAS REGISTERED ON 25/09/2020

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ellington House 9 Savannah Way Leeds Valley Park Leeds West Yorkshire LS10 1AB zum Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL am 02. Jan. 2020

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Dez. 2019

    LRESSP

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2019

    • Kapital: GBP 4.01
    3 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    18 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 050695130015, erstellt am 08. Mai 2019

    22 SeitenMR01

    Beendigung der Bestellung von James John Cornell als Geschäftsführer am 02. Apr. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 050695130014, erstellt am 20. Nov. 2018

    22 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    17 SeitenAA

    Ernennung von Mr John Simon Pears als Direktor am 19. Juni 2018

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von LOWELL FINANCE LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FLAHERTY, John Patrick
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    West Midlands
    Geschäftsführer
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    West Midlands
    EnglandIrish222835470001
    PEARS, John Simon
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    West Midlands
    Geschäftsführer
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    West Midlands
    EnglandBritish257612020001
    ANNETT, Richard
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    Sekretär
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    210099720001
    CORNELL, James John
    The Barn
    Hough Side Lane Pudsey
    LS28 9JH Leeds
    Sekretär
    The Barn
    Hough Side Lane Pudsey
    LS28 9JH Leeds
    British97870490004
    FLYNN, Bill
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp 1
    Sekretär
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp 1
    241711050001
    GILBERT, Michael Andrew
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Sekretär
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    188194450001
    LECKENBY, Sara Louise
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    Enterprise House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    Enterprise House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    170347120001
    SCREETON, Philip
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    Sekretär
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    British79502860002
    OFFICE ORGANISATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Sekretär
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    94451380001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Sekretär
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARTLE, Andrew Paul
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish92477660007
    BRIGGS, Dominic Patrick
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish209503140001
    CORNELL, James John
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish97870490006
    DAVIES, Richard Llewellyn
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish100793180001
    EDWARDS, Gary James
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish176103330001
    LECKENBY, Sara Louise
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish169702140001
    LYNN- JONES, Michael Gerard
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish196266630001
    LYNN-JONES, Michael Gerard
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish196266110001
    MAGRANE, Sarah Ann
    1a Old Park Road
    LS8 1JT Leeds
    Geschäftsführer
    1a Old Park Road
    LS8 1JT Leeds
    British104102010003
    NEWMAN, Joyce Elizabeth
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish96410390003
    SALES, Christopher Michael
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    West Yorkshire
    British90365300003
    SCREETON, Philip
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    Geschäftsführer
    Enterprise House
    1 Apex View
    LS11 9BH Leeds
    United KingdomBritish79502860002
    STORRAR, Colin George
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish176079790001
    TREPEL, Christopher
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    9 Savannah Way
    Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    West Yorkshire
    United KingdomAmerican210141050001
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Geschäftsführer
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    77973430001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOWELL FINANCE LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Savannah Way, Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    England
    06. Apr. 2016
    Savannah Way, Leeds Valley Park
    LS10 1AB Leeds
    Ellington House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2005
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05069357
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat LOWELL FINANCE LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Mai 2019
    Geliefert am 13. Mai 2019
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    N/A.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Nov. 2018
    Geliefert am 01. Dez. 2018
    Ausstehend
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 09. Dez. 2015
    Geliefert am 21. Dez. 2015
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Citibank, N.A., London Branch
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 09. Juni 2015
    Geliefert am 11. Juni 2015
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Jp Morgan Europe Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 11. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. März 2014
    Geliefert am 13. März 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (As "Security Agent")
    Transaktionen
    • 13. März 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Nov. 2013
    Geliefert am 13. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 2012
    Geliefert am 04. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 21. Okt. 2010
    Geliefert am 25. Okt. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the senior finance parties and the mezzanine parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security document
    Erstellt am 04. Apr. 2008
    Geliefert am 16. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all its present and future right title and interest in or to the accounts,any financial assets,all causes of action,all contractual rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Europe Arab Bank PLC (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    The fixed and floating security document
    Erstellt am 29. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in or to: the accounts, any financial assets, all causes of action, all contractual rights, all investments, the insurances, all uncalled capital and goodwill, all intellectual property, all beneficial interests in any pension funds, the files, all dividends and all receivables. By way of floating charge its undertaking and all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Europe Arab Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 15. Mai 2006
    Geliefert am 25. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its present and future right title and interest in the accounts, all investments all uncalled capital and goodwill by way of floating charge its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent) for and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 12. Okt. 2005
    Geliefert am 20. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the acounts any financial assets all investments the insurances all uncalled capital and goodwill all dividends floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of the Finance Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 10. Aug. 2005
    Geliefert am 25. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its present and future right title and interest in the accounts, all investments all uncalled capital and goodwill by way of floating charge its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 16. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge, all its present and future right, title and interest in and to: the accounts; any financial assets; all causes of action; all contractual rights; all investments; the insurances; all uncalled capital and goodwill; all intellectual property; all beneficial interests in any pension funds; the files; all dividends, all receivables; each excluded assignment account purchase agreement and the portfolio accounts;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 16. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LOWELL FINANCE LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Dez. 2019Beginn der Liquidation
    10. Juni 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praktiker
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0