LOWELL FINANCE LTD
Überblick
| Unternehmensname | LOWELL FINANCE LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05069513 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOWELL FINANCE LTD?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LOWELL FINANCE LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LOWELL FINANCE LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KYTE HOLDINGS 2 LIMITED | 10. Mai 2004 | 10. Mai 2004 |
| PRECIS (2411) LIMITED | 10. März 2004 | 10. März 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOWELL FINANCE LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOWELL FINANCE LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 16. Feb. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Dez. 2021 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 05. Sept. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 02. Juli 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Dez. 2020 | 20 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Zweite Einreichung der Bestätigungserklärung vom 30. März 2020 | 3 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bill Flynn als Sekretär am 30. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. März 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ellington House 9 Savannah Way Leeds Valley Park Leeds West Yorkshire LS10 1AB zum Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL am 02. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 050695130015, erstellt am 08. Mai 2019 | 22 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James John Cornell als Geschäftsführer am 02. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 050695130014, erstellt am 20. Nov. 2018 | 22 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr John Simon Pears als Direktor am 19. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LOWELL FINANCE LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAHERTY, John Patrick | Geschäftsführer | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | England | Irish | 222835470001 | |||||
| PEARS, John Simon | Geschäftsführer | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | England | British | 257612020001 | |||||
| ANNETT, Richard | Sekretär | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire | 210099720001 | |||||||
| CORNELL, James John | Sekretär | The Barn Hough Side Lane Pudsey LS28 9JH Leeds | British | 97870490004 | ||||||
| FLYNN, Bill | Sekretär | City Square LS1 2AL Leeds Deloitte Llp 1 | 241711050001 | |||||||
| GILBERT, Michael Andrew | Sekretär | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | 188194450001 | |||||||
| LECKENBY, Sara Louise | Sekretär | 1 Apex View LS11 9BH Leeds Enterprise House West Yorkshire United Kingdom | 170347120001 | |||||||
| SCREETON, Philip | Sekretär | Enterprise House 1 Apex View LS11 9BH Leeds | British | 79502860002 | ||||||
| OFFICE ORGANISATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 94451380001 | |||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Sekretär | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARTLE, Andrew Paul | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 92477660007 | |||||
| BRIGGS, Dominic Patrick | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 209503140001 | |||||
| CORNELL, James John | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | England | British | 97870490006 | |||||
| DAVIES, Richard Llewellyn | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 100793180001 | |||||
| EDWARDS, Gary James | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | England | British | 176103330001 | |||||
| LECKENBY, Sara Louise | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 169702140001 | |||||
| LYNN- JONES, Michael Gerard | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 196266630001 | |||||
| LYNN-JONES, Michael Gerard | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 196266110001 | |||||
| MAGRANE, Sarah Ann | Geschäftsführer | 1a Old Park Road LS8 1JT Leeds | British | 104102010003 | ||||||
| NEWMAN, Joyce Elizabeth | Geschäftsführer | Enterprise House 1 Apex View LS11 9BH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 96410390003 | |||||
| SALES, Christopher Michael | Geschäftsführer | Enterprise House 1 Apex View LS11 9BH Leeds West Yorkshire | British | 90365300003 | ||||||
| SCREETON, Philip | Geschäftsführer | Enterprise House 1 Apex View LS11 9BH Leeds | United Kingdom | British | 79502860002 | |||||
| STORRAR, Colin George | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 176079790001 | |||||
| TREPEL, Christopher | Geschäftsführer | 9 Savannah Way Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House West Yorkshire | United Kingdom | American | 210141050001 | |||||
| PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 77973430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOWELL FINANCE LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowell Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Savannah Way, Leeds Valley Park LS10 1AB Leeds Ellington House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LOWELL FINANCE LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 08. Mai 2019 Geliefert am 13. Mai 2019 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung N/A. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Nov. 2018 Geliefert am 01. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 09. Dez. 2015 Geliefert am 21. Dez. 2015 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 09. Juni 2015 Geliefert am 11. Juni 2015 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 11. März 2014 Geliefert am 13. März 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 28. Nov. 2013 Geliefert am 13. Dez. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 2012 Geliefert am 04. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 21. Okt. 2010 Geliefert am 25. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the senior finance parties and the mezzanine parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security document | Erstellt am 04. Apr. 2008 Geliefert am 16. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge all its present and future right title and interest in or to the accounts,any financial assets,all causes of action,all contractual rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| The fixed and floating security document | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 19. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in or to: the accounts, any financial assets, all causes of action, all contractual rights, all investments, the insurances, all uncalled capital and goodwill, all intellectual property, all beneficial interests in any pension funds, the files, all dividends and all receivables. By way of floating charge its undertaking and all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 15. Mai 2006 Geliefert am 25. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its present and future right title and interest in the accounts, all investments all uncalled capital and goodwill by way of floating charge its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 12. Okt. 2005 Geliefert am 20. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to the acounts any financial assets all investments the insurances all uncalled capital and goodwill all dividends floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 10. Aug. 2005 Geliefert am 25. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its present and future right title and interest in the accounts, all investments all uncalled capital and goodwill by way of floating charge its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 11. März 2005 Geliefert am 16. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any finance party or to any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge, all its present and future right, title and interest in and to: the accounts; any financial assets; all causes of action; all contractual rights; all investments; the insurances; all uncalled capital and goodwill; all intellectual property; all beneficial interests in any pension funds; the files; all dividends, all receivables; each excluded assignment account purchase agreement and the portfolio accounts;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LOWELL FINANCE LTD Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0