UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05077315 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | South Quay Temple Back BS1 6FL Bristol United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 6 LIMITED | 18. März 2004 | 18. März 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Lloyd Watts als Geschäftsführer am 11. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Ldc (Holdings) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Change of details for Ldc (Holdings) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Core St Thomas Street Bristol BS1 6JX zum South Quay Temple Back Bristol BS1 6FL am 24. März 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Faulkner als Direktor am 27. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Lloyd Watts als Direktor am 26. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Guy Richards als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Christopher Allan als Geschäftsführer am 20. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Christopher Allan am 17. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Christopher Allan am 12. Okt. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Joseph Julian Lister am 27. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Guy Richards am 23. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Guy Richards am 21. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Robert Szpojnarowicz am 09. Sept. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Sekretär | Temple Back BS1 6FL Bristol South Quay United Kingdom | British | 175753180001 | ||||||
FAULKNER, David | Geschäftsführer | Temple Back BS1 6FL Bristol South Quay United Kingdom | United Kingdom | British | Deputy Cfo | 219353910001 | ||||
LISTER, Joseph Julian | Geschäftsführer | Temple Back BS1 6FL Bristol South Quay United Kingdom | England | British | Corporate Finance Manager | 124180960001 | ||||
SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert | Geschäftsführer | Temple Back BS1 6FL Bristol South Quay United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary/Head Of Legal | 175753180001 | ||||
REID, Andrew Donald | Sekretär | 15 Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol | British | 67884910002 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ALLAN, Mark Christopher | Geschäftsführer | St Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | England | British | Group Finance Director | 74371010007 | ||||
BENNETT, Michael Peter | Geschäftsführer | 45 Drakes Way Portishead BS20 6LD Bristol | England | British | Financial Controller | 86546430001 | ||||
GRANGER, James Winston Edward | Geschäftsführer | Southdale 48 Greenway Lane BA2 4LW Bath | England | British | Chartered Accountant | 119802100001 | ||||
GRANT, Stephen Richard | Geschäftsführer | Alma Road Clifton BS8 2BY Bristol 12 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 146103670002 | ||||
MAYLER, Mark Antony | Geschäftsführer | 15 Fosse Lane BS48 2AR Nailsea North Somerset | United Kingdom | British | Accountant | 163764940001 | ||||
MCDONALD, David Andrew | Geschäftsführer | Cherith Church Lane Chew Stoke BS40 8TU Bristol Avon | England | British | Company Director | 67201010001 | ||||
REID, Andrew Donald | Geschäftsführer | Cranbrook Road Redland BS6 7BJ Bristol 15 England | United Kingdom | British | Solicitor | 67884910002 | ||||
RICHARDS, Nicholas Guy | Geschäftsführer | St Thomas Street BS1 6JX Bristol The Core | England | British | Chartered Accountant | 122256380002 | ||||
WATTS, James Lloyd | Geschäftsführer | Temple Back BS1 6FL Bristol South Quay United Kingdom | England | British | Director | 217176690001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ldc (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Temple Back BS1 6FL Bristol South Quay House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 06. März 2009 Geliefert am 11. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Full title guarantee charged to the agent as trustee for the finance parties by way of legal mortgage the property. Assigned to the agent as trustee for the finance parties its interest in the rental income and. Charged to the agent as trusteee for the finance parties by way of fixed charge its interest in any present and future insurances in respect of any charged property and the proceeds of such insurances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 21. Aug. 2008 Geliefert am 14. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the lease under t/n mid 100346 34-38 and 40 potterow, edinburgh. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Aug. 2008 Geliefert am 22. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a canto court, 122-128 (even) old street, london interest in the rental income, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 06 september 2007 and | Erstellt am 15. Aug. 2007 Geliefert am 25. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the property k/a panmure court 32 carlton road edinburgh t/n MID25554. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. März 2007 Geliefert am 16. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H 37 to 41 (odd numbers) green lanes london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Dez. 2006 Geliefert am 18. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties ona ny account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H beaumont court 15-23 pancras way london, l/h bernard myers house 4-6 havil street london and l/h somerset court at aldenham street werrington street polygon road and charlton street london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Nov. 2006 Geliefert am 15. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge its beneficial interest in each property being sub-underlease dated 3 october 2003 made between ldc (imperial wharf) limited (1) and ldc (imperial wharf two) limited (2). lease dated 1 september 2005 and made between ldc (capital cities nominee no.1) limited and (1) ldc (capital cities nominee no.2) limited and the chargor (2). for further details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 16 november 2006 and | Erstellt am 12. Okt. 2006 Geliefert am 29. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects lady lawson street edinburgh in the county fo midlothian t/no MID1597. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. Sept. 2006 Geliefert am 06. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a beaumont court 15-23 st pancras way london. L/h property k/a bernard myers house 4-6 havil street london. L/h property k/a somerset court being land between aldenham street werrington st polygon road and charlton street london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Sept. 2006 Geliefert am 16. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 15 september 2006 and | Erstellt am 06. Sept. 2006 Geliefert am 03. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole subjects k/a numbers 27 to 31 james craig walk, edinburgh I the county of midlothian t/n MID39754. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 13. Okt. 2005 Geliefert am 19. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligot to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a 457,459,461 and 463 caledonian road,l/h property k/a mary branker house 54 TO74 (even) holmes road london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 08. März 2005 Geliefert am 17. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The whole of the assets, property, and undertaking of the company whatsoever. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 9TH march 2005 | Erstellt am 08. März 2005 Geliefert am 17. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property k/a 27 to 31 james craig walk, edinburgh, t/no MID39754 t/nos MID54079 and MID39754. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. März 2005 Geliefert am 17. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (as agent and trustee for the finance parties (as therein defined)) (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 and 60 holmes road kentish town t/n LN126897; f/h property k/a 62 and 64 holmes road knetish town t/n LN198452; f/h property k/a 66, 68, 70, 72 and 74 holmes road kentish town NW5 3AB t/n LN73278; for details of further properties charged, please refer to form M395;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0