UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED

UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameUNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05077315
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    South Quay
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 6 LIMITED18. März 200418. März 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    18 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von James Lloyd Watts als Geschäftsführer am 11. Apr. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Change of details for Ldc (Holdings) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2017

    2 SeitenPSC05

    Change of details for Ldc (Holdings) Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2017

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Core St Thomas Street Bristol BS1 6JX zum South Quay Temple Back Bristol BS1 6FL am 24. März 2017

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr David Faulkner als Direktor am 27. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr James Lloyd Watts als Direktor am 26. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    17 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Guy Richards als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Christopher Allan als Geschäftsführer am 20. Mai 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. März 2016

    Kapitalaufstellung am 23. März 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Christopher Allan am 17. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Christopher Allan am 12. Okt. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Joseph Julian Lister am 27. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Guy Richards am 23. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Guy Richards am 21. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Robert Szpojnarowicz am 09. Sept. 2015

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    Sekretär
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    British175753180001
    FAULKNER, David
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    United KingdomBritishDeputy Cfo219353910001
    LISTER, Joseph Julian
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    EnglandBritishCorporate Finance Manager124180960001
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary/Head Of Legal175753180001
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Sekretär
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    British67884910002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLAN, Mark Christopher
    St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Geschäftsführer
    St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    EnglandBritishGroup Finance Director74371010007
    BENNETT, Michael Peter
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    Geschäftsführer
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    EnglandBritishFinancial Controller86546430001
    GRANGER, James Winston Edward
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    Geschäftsführer
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    EnglandBritishChartered Accountant119802100001
    GRANT, Stephen Richard
    Alma Road
    Clifton
    BS8 2BY Bristol
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Alma Road
    Clifton
    BS8 2BY Bristol
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant146103670002
    MAYLER, Mark Antony
    15 Fosse Lane
    BS48 2AR Nailsea
    North Somerset
    Geschäftsführer
    15 Fosse Lane
    BS48 2AR Nailsea
    North Somerset
    United KingdomBritishAccountant163764940001
    MCDONALD, David Andrew
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    EnglandBritishCompany Director67201010001
    REID, Andrew Donald
    Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    15
    England
    Geschäftsführer
    Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    15
    England
    United KingdomBritishSolicitor67884910002
    RICHARDS, Nicholas Guy
    St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Geschäftsführer
    St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    EnglandBritishChartered Accountant122256380002
    WATTS, James Lloyd
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector 217176690001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ldc (Holdings) Limited
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay House
    England
    06. Apr. 2016
    Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    South Quay House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer02625007
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat UNITE ACCOMMODATION MANAGEMENT 8 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 2009
    Geliefert am 11. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Full title guarantee charged to the agent as trustee for the finance parties by way of legal mortgage the property. Assigned to the agent as trustee for the finance parties its interest in the rental income and. Charged to the agent as trusteee for the finance parties by way of fixed charge its interest in any present and future insurances in respect of any charged property and the proceeds of such insurances see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 11. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 21. Aug. 2008
    Geliefert am 14. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the lease under t/n mid 100346 34-38 and 40 potterow, edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 2008
    Geliefert am 22. Aug. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a canto court, 122-128 (even) old street, london interest in the rental income, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 06 september 2007 and
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the property k/a panmure court 32 carlton road edinburgh t/n MID25554. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 08. März 2007
    Geliefert am 16. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H 37 to 41 (odd numbers) green lanes london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 16. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2006
    Geliefert am 18. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties ona ny account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H beaumont court 15-23 pancras way london, l/h bernard myers house 4-6 havil street london and l/h somerset court at aldenham street werrington street polygon road and charlton street london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Nov. 2006
    Geliefert am 15. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge its beneficial interest in each property being sub-underlease dated 3 october 2003 made between ldc (imperial wharf) limited (1) and ldc (imperial wharf two) limited (2). lease dated 1 september 2005 and made between ldc (capital cities nominee no.1) limited and (1) ldc (capital cities nominee no.2) limited and the chargor (2). for further details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 23. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 16 november 2006 and
    Erstellt am 12. Okt. 2006
    Geliefert am 29. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects lady lawson street edinburgh in the county fo midlothian t/no MID1597. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag London Branch as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 06. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a beaumont court 15-23 st pancras way london. L/h property k/a bernard myers house 4-6 havil street london. L/h property k/a somerset court being land between aldenham street werrington st polygon road and charlton street london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 07. Sept. 2006
    Geliefert am 16. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 23. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 15 september 2006 and
    Erstellt am 06. Sept. 2006
    Geliefert am 03. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole subjects k/a numbers 27 to 31 james craig walk, edinburgh I the county of midlothian t/n MID39754.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 13. Okt. 2005
    Geliefert am 19. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligot to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 457,459,461 and 463 caledonian road,l/h property k/a mary branker house 54 TO74 (even) holmes road london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 08. März 2005
    Geliefert am 17. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole of the assets, property, and undertaking of the company whatsoever.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 17. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 9TH march 2005
    Erstellt am 08. März 2005
    Geliefert am 17. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a 27 to 31 james craig walk, edinburgh, t/no MID39754 t/nos MID54079 and MID39754.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 17. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. März 2005
    Geliefert am 17. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (as agent and trustee for the finance parties (as therein defined)) (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 and 60 holmes road kentish town t/n LN126897; f/h property k/a 62 and 64 holmes road knetish town t/n LN198452; f/h property k/a 66, 68, 70, 72 and 74 holmes road kentish town NW5 3AB t/n LN73278; for details of further properties charged, please refer to form M395;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0