CORPBRANCH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CORPBRANCH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05079421 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CORPBRANCH LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich CORPBRANCH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gable House 239 Regents Park Road N3 3LF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CORPBRANCH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CORPBRANCH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 21 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 19-20 Bourne Court Southend Road Woodford Green Essex IG8 8HD United Kingdom am 21. Apr. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Rust als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Adams als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bruce Ritchie als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2010 bis 10. Mai 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CORPBRANCH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS, Mark | Geschäftsführer | Hilltop Court 14-16 Alexandra Road NW8 0DR London 16 England | England | British | 128037810001 | |||||
| EDWARDS, Thomas George | Sekretär | Flat 5 77 Coswell Road EC1V 7ER London | British | 125331690001 | ||||||
| GREVILLE, Helen Mary | Sekretär | 141 Dawpool Road Cricklewood NW2 7LA London | British | 110788860001 | ||||||
| RAYMOND, Louise Charlotte | Sekretär | 11 Freelands Grove BR1 3LH Bromley Kent | British | 124463060001 | ||||||
| RUST, Jonathan Simon David Anthony | Sekretär | 17 Hayton Close LU3 4HD Luton Bedfordshire | British | 91991430001 | ||||||
| VINER, Paul Lewis | Sekretär | Deansway N2 0JF London 24 United Kingdom | British | 117768960004 | ||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| ISAACS, David Henry | Geschäftsführer | 2 Half Acre 67-69 Woodford Road E18 2EX London | United Kingdom | British | 10567190001 | |||||
| RITCHIE, Bruce Weir | Geschäftsführer | Park Street Westminster W1K 2JG London 40 United Kingdom | England | British | 61895720002 | |||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Hat CORPBRANCH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed | Erstellt am 13. Sept. 2007 Geliefert am 22. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other fund 1 security beneficiaries (or any of them) and from the company to the chargee and/or the other fund 2 security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Sept. 2007 Geliefert am 22. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other fund 1 security beneficiaries (or any of them) and/or the other fund 2 security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Flats 27 and 29 forest court 140 edgware road london t/no NGL841359 and NGL841354. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Juni 2004 Geliefert am 14. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Juni 2004 Geliefert am 14. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 27 forset court edgware road london;flat 29 forset court edgware road london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CORPBRANCH LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0