CROFTON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCROFTON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05080013
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CROFTON LIMITED?

    • Andere Vergnügungs- und Erholungsaktivitäten n.a. (93290) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich CROFTON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Lynton House Ackhurst Park
    Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CROFTON LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PONTIN'S LIMITED01. März 200601. März 2006
    HALLCO 1030 LIMITED22. März 200422. März 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROFTON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für CROFTON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    13 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Gleadhill House Dawbers Lane Euxton Chorley Lancashire PR7 6EA zum Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road Chorley Lancashire PR7 1NY am 09. Juni 2017

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 05. Juni 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Craig John Hemmings am 05. Juni 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Lorimer Widders am 05. Juni 2017

    1 SeitenCH03

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 05. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Mr Craig John Hemmings als Direktor am 31. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Mark Lorimer Widders als Sekretär am 31. Dez. 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von St John Stott als Sekretär am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von St John Stott als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Mark Lorimer Widders als Direktor am 11. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Dean Leonard Harding als Geschäftsführer am 16. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CROFTON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Sekretär
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    203883240001
    HEMMINGS, Craig John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishCompany Director180952730001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    EnglandBritishDirector2272770002
    FREEMAN, Paul Stephen
    40 Sheep Hill Lane
    Clayton Le Woods
    PR6 7JH Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    40 Sheep Hill Lane
    Clayton Le Woods
    PR6 7JH Chorley
    Lancashire
    BritishDirector52600500001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Sekretär
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    British83024660001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Sekretär
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    BritishDirector83024660001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    EDWARDS, George Albert
    12 Gronant Road
    LL19 9DS Prestatyn
    Clwyd
    Geschäftsführer
    12 Gronant Road
    LL19 9DS Prestatyn
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector52691650002
    GEMSON, Michael
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    BritishDirector363340001
    HARDING, Dean Leonard
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector58933060001
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector180952730001
    HOMER, Colin David
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector1850120001
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritishDirector27891540001
    RODEN, John Keith Dennis
    Crowshaws House The Barn
    Little Scotland Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Crowshaws House The Barn
    Little Scotland Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Lancashire
    BritishDirector1771410001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector83024660001
    SULLIVAN, Christopher John
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishDirector101400140001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CROFTON LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Cuerden Leisure Limited
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    England
    06. Apr. 2016
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageEngland
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CROFTON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Mai 2011
    Geliefert am 21. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juli 2007
    Geliefert am 31. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Lease dated 21 february 2006. all that property being blackpool holiday centre,clifton drive north, lytham st annes, lancashire t/n LA521862 and the land adjoi. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Mai 2007
    Geliefert am 05. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at rosemoor caravan park south road brean t/no ST93944 l/h land at pontin's holiday centre barkby avenue prestatyn t/no CYM242361 l/h land and buildings at southport holiday village shore road ainsdale southport t/no MS522950. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2006
    Geliefert am 06. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0