CROFTON LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CROFTON LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05080013 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CROFTON LIMITED?
- Andere Vergnügungs- und Erholungsaktivitäten n.a. (93290) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich CROFTON LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CROFTON LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PONTIN'S LIMITED | 01. März 2006 | 01. März 2006 |
HALLCO 1030 LIMITED | 22. März 2004 | 22. März 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROFTON LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CROFTON LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gleadhill House Dawbers Lane Euxton Chorley Lancashire PR7 6EA zum Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road Chorley Lancashire PR7 1NY am 09. Juni 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 05. Juni 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Craig John Hemmings am 05. Juni 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Lorimer Widders am 05. Juni 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Craig John Hemmings als Direktor am 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Lorimer Widders als Sekretär am 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von St John Stott als Sekretär am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von St John Stott als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Lorimer Widders als Direktor am 11. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dean Leonard Harding als Geschäftsführer am 16. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CROFTON LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDDERS, Mark Lorimer | Sekretär | Dawbers Lane Euxton PR7 6ED Chorley Dower House Lancashire England | 203883240001 | |||||||
HEMMINGS, Craig John | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6ED Chorley Dower House Lancashire England | United Kingdom | British | Company Director | 180952730001 | ||||
WIDDERS, Mark Lorimer | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6ED Chorley Dower House Lancashire England | England | British | Director | 2272770002 | ||||
FREEMAN, Paul Stephen | Sekretär | 40 Sheep Hill Lane Clayton Le Woods PR6 7JH Chorley Lancashire | British | Director | 52600500001 | |||||
STOTT, St John | Sekretär | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | British | 83024660001 | ||||||
STOTT, St John | Sekretär | 17 Uplands Chase Fulwood PR2 7AW Preston | British | Director | 83024660001 | |||||
HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||
EDWARDS, George Albert | Geschäftsführer | 12 Gronant Road LL19 9DS Prestatyn Clwyd | United Kingdom | British | Director | 52691650002 | ||||
GEMSON, Michael | Geschäftsführer | Kingsway House 4 Kingsway Penwortham PR1 0AP Preston Lancashire | British | Director | 363340001 | |||||
HARDING, Dean Leonard | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | United Kingdom | British | Director | 58933060001 | ||||
HEMMINGS, Craig John | Geschäftsführer | Charnock House Preston Road Charnock Richard PR7 5LH Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 180952730001 | ||||
HOMER, Colin David | Geschäftsführer | 39 The Avenue Ingol PR2 7AX Preston Lancashire | United Kingdom | British | Director | 1850120001 | ||||
KAY, John Clement | Geschäftsführer | 7 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | Director | 27891540001 | ||||
RODEN, John Keith Dennis | Geschäftsführer | Crowshaws House The Barn Little Scotland Blackrod BL6 5JJ Bolton Lancashire | British | Director | 1771410001 | |||||
STOTT, St John | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | United Kingdom | British | Director | 83024660001 | ||||
SULLIVAN, Christopher John | Geschäftsführer | 8 Spring Gardens Waddington BB7 3HH Blackburn Lancashire | England | British | Director | 101400140001 | ||||
HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013270001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CROFTON LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerden Leisure Limited | 06. Apr. 2016 | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CROFTON LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 12. Mai 2011 Geliefert am 21. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2007 Geliefert am 31. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Lease dated 21 february 2006. all that property being blackpool holiday centre,clifton drive north, lytham st annes, lancashire t/n LA521862 and the land adjoi. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Mai 2007 Geliefert am 05. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at rosemoor caravan park south road brean t/no ST93944 l/h land at pontin's holiday centre barkby avenue prestatyn t/no CYM242361 l/h land and buildings at southport holiday village shore road ainsdale southport t/no MS522950. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Sept. 2006 Geliefert am 06. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0