MODUS (MCP) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMODUS (MCP) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05080206
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MODUS (MCP) LIMITED?

    • (7012) /

    Wo befindet sich MODUS (MCP) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MODUS (MCP) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BRONZELAKE LIMITED22. März 200422. März 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MODUS (MCP) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für MODUS (MCP) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Edge Clowes Street Salford M3 5NA United Kingdom am 24. Aug. 2010

    1 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 11. Aug. 2010

    LRESEX

    Beendigung der Bestellung von Damian Flood als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Apr. 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Edge Clowes Street Manchester Greater Manchester M3 5NB am 19. Apr. 2010

    1 SeitenAD01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    13 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    13 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    13 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von MODUS (MCP) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, John Elwyn
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    British84729210001
    FLOOD, Brendan
    Mowbray
    Leigh Road Worsley
    M28 2QU Manchester
    Geschäftsführer
    Mowbray
    Leigh Road Worsley
    M28 2QU Manchester
    EnglandBritishProperty Developer38787790002
    FLOOD, Brendan
    40 Cavendish Road Ellesmere Park
    Eccles
    M30 9JF Manchester
    Sekretär
    40 Cavendish Road Ellesmere Park
    Eccles
    M30 9JF Manchester
    BritishProperty Developer38787790001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    FLOOD, Damian
    4 New Bank Close
    Dobcross
    OL3 5LE Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    4 New Bank Close
    Dobcross
    OL3 5LE Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishProperty Developer99422430001
    RIDDELL, James Michael Charles
    Brook Road
    WA13 9AH Lymm
    2
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brook Road
    WA13 9AH Lymm
    2
    Cheshire
    EnglandBritishProperty Developer60942110002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Hat MODUS (MCP) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of legal charge
    Erstellt am 03. Aug. 2005
    Geliefert am 13. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Geopost site millenium city park preston t/no LA935887 and new city house ringway preston t/no's LA408632 and LA606472 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 03. Aug. 2005
    Geliefert am 13. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Security assignment of a building contract
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or barnfield electronic house limited who together form the modus barnfield partnership to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in the jct standard form of building contract 1998 edition. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 16. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The building contract and all rights and benefits of whatever nature accruing to the partnership from time to time under and/or pursuant to the building contract. The proceeds of any claims damages awards and/or judgements which are or which may be received or receivable by the assignor under and/or pursuant to the building contract and all agreements contracts deeds undertakings guarantees warranties and other documents now or hereafter in existence under or in relation to the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of agreement for lease
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 16. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The agreement dated 5TH march 2004. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of agreement for sale entered into by the modus barnfield partnership (partnership)
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    An agreement (agreement) dated 9 october 2003 and made between modus developments limited and volkswagen financial services (UK) limited, the benefits of which were assigned and transferred to the partnership by way of transfer documentation dated 31 march 2004.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of agreement for sale entered into by the modus barnfield partnership (partnership)
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    An agreement (agreement) dated 23 may 2003 and made between modus developments limited and wyder developments limited, the benefits of which were assigned and transferred to the partnership by way of transfer documentation dated 31 march 2004.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge entered into by the modus barnfield partnership (partnership)
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h land situate electronic house, ring way, preston, t/nos LA408632 and LA606472; all the fixtures and fittings of the partnership from time to time attached to the property; all the plant and machinery vehicles and computer equipment of the partnership; all the furniture furnishings equipment of the partnership now and in the future at the property; the rent receivable from any lease granted out of the property and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge entered into by the modus barnfield partnership (partnership)
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land situate on the north west side of longridge road, preston, and known as millennium city park, longridge road, preston, t/no LA935887; all the fixtures and fittings of the partnership from time to time attached to the property; all the plant and machinery vehicles and computer equipment of the partnership; all the furniture furnishings equipment of the partnership now and in the future at the property; the rents receivable from any lease granted out of the property and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 2004
    Geliefert am 07. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a millennium city park longridge road preston t/n LA935887 and the l/h property k/a electronic house ring way preston t/n LA408632 and LA606472. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MODUS (MCP) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Aug. 2010Beginn der Liquidation
    12. Apr. 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Leonard Conn
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Gary Norton Lee
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0