PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED

PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05081105
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ONE ONE ONE LIMITED15. Dez. 200415. Dez. 2004
    PROTECTAGROUP LIMITED03. Nov. 200403. Nov. 2004
    ONE ONE ONE LIMITED23. März 200423. März 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Dean Clarke als Sekretär am 22. Feb. 2022

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Ardonagh Corporate Secretary Limited als Sekretär am 22. Feb. 2022

    2 SeitenAP04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    22 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2021 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2020

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium of £1628000 be reduced to nil - credited to retained reserves 01/12/2020
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    4 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Minster Court London EC3R 7AA United Kingdom zum 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD am 14. Juli 2020

    1 SeitenAD01

    Change of details for Protectagroup Acquisitions Limited as a person with significant control on 14. Juli 2020

    2 SeitenPSC05

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Protectagroup Acquisitions Limited as a person with significant control on 30. Juli 2019

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    20 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Antonios Erotocritou als Geschäftsführer am 01. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ms Diane Cougill als Direktor am 01. Aug. 2019

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 1 Minster Court London EC3R 7AA am 30. Juli 2019

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 050811050009 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Sekretär
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer03702575
    288842300001
    COUGILL, Diane
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Finance Officer158614590002
    ROSS, David Christopher
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandIrishDirector222326970001
    BROWN, Ian William
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    BritishDirector262382040001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Sekretär
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253939990001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249087180001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221972880001
    KIRKNESS, Barrie
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    Sekretär
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    British103733180001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Sekretär
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183326340001
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Sekretär
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    BritishInsurance Broker67745500003
    KTS SECRETARIES LIMITED
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    Sekretär
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    84474590001
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector125097020001
    BRICE, Ian Charles
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    BritishChairman63706880001
    BROWN, Ian William
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishCompliance Director262382040001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Geschäftsführer
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritishCompany Director134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector171398800001
    CHARD, Michael Francis
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    Geschäftsführer
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    UkBritishChairman45725420009
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector149939610001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriotDeputy Cfo167795710001
    EVANS, Ieuan Cennydd
    Ysgubor Goch
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Ysgubor Goch
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishDirector66329000004
    HAGGETT, Linda
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    Geschäftsführer
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    United KingdomWelshInsurance Broker137893590001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Geschäftsführer
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritishCompany Director129538180001
    LYONS, Alastair David
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishExecutive Chairman193700540001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishDirector162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector113694470002
    POWELL, Kenneth John
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    WalesBritishDirector27317930001
    RAGAN, Paul Robert
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritishManaging Director60263070005
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector147194830001
    RIDEWOOD, Gary Spencer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritishFinance Director112745560001
    WIGLEY, William George
    46 Heol St Cattwg
    Pendoylan
    CF71 7UG Cowbridge
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    46 Heol St Cattwg
    Pendoylan
    CF71 7UG Cowbridge
    South Glamorgan
    WalesBritishDirector193333870002
    KTS NOMINEES LIMITED
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    Geschäftsführer
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    84474580001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Protectagroup Acquisitions Limited
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House Cardiff
    Registrierungsnummer06512090
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2015
    Geliefert am 22. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    By way of first legal mortgage all legal interest in trademark registration/application number 2413912 as listed in schedule 5 (intellectual property) of the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 18. Feb. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Mai 2013
    Geliefert am 23. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Pursuant to clause 3.1(b)(vii) of the charge, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property, including the following:. Trademark registration/application number 2413912.. pursuant to the charge, the company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security accession deed
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 07. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 06. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 06. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2010
    Geliefert am 18. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession
    Erstellt am 04. Juni 2008
    Geliefert am 17. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2006
    Geliefert am 04. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2004
    Geliefert am 20. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2004
    Geliefert am 21. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0