PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05081105 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ONE ONE ONE LIMITED | 15. Dez. 2004 | 15. Dez. 2004 |
PROTECTAGROUP LIMITED | 03. Nov. 2004 | 03. Nov. 2004 |
ONE ONE ONE LIMITED | 23. März 2004 | 23. März 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dean Clarke als Sekretär am 22. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Ardonagh Corporate Secretary Limited als Sekretär am 22. Feb. 2022 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Minster Court London EC3R 7AA United Kingdom zum 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD am 14. Juli 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Change of details for Protectagroup Acquisitions Limited as a person with significant control on 14. Juli 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Protectagroup Acquisitions Limited as a person with significant control on 30. Juli 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Antonios Erotocritou als Geschäftsführer am 01. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Diane Cougill als Direktor am 01. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 1 Minster Court London EC3R 7AA am 30. Juli 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 050811050009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom |
| 288842300001 | ||||||||||
COUGILL, Diane | Geschäftsführer | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | England | British | Chief Finance Officer | 158614590002 | ||||||||
ROSS, David Christopher | Geschäftsführer | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | England | Irish | Director | 222326970001 | ||||||||
BROWN, Ian William | Sekretär | 36 Beech Wood Drive Tonyrefail CF39 8JE Rhondda Cynon Taff Mid Glamorgan | British | Director | 262382040001 | |||||||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | British | 117669700002 | ||||||||||
CLARKE, Dean | Sekretär | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | 253939990001 | |||||||||||
GOURIET, Geoffrey Costerton | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 249087180001 | |||||||||||
GREGORY, Jacqueline Anne | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | 221972880001 | |||||||||||
KIRKNESS, Barrie | Sekretär | 76 Glan Y Ffordd CF15 7SL Taffs Well South Glamorgan | British | 103733180001 | ||||||||||
OWENS, Jennifer | Sekretär | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | 183326340001 | |||||||||||
RAGAN, Sharon Marie | Sekretär | Old Tregyrnog Farmhouse St Brides Super Ely CF5 6EZ Cardiff | British | Insurance Broker | 67745500003 | |||||||||
KTS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Counting House Dunleavy Drive CF11 0SN Cardiff | 84474590001 | |||||||||||
BARR, Graham Maxwell | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Director | 125097020001 | ||||||||
BRICE, Ian Charles | Geschäftsführer | Sycamore Cottage Bonvilston CF5 6TR Cardiff South Glamorgan | British | Chairman | 63706880001 | |||||||||
BROWN, Ian William | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Compliance Director | 262382040001 | ||||||||
BROWN, Roger Michael | Geschäftsführer | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | Company Director | 134140540001 | ||||||||
BRUCE, David James | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Director | 171398800001 | ||||||||
CHARD, Michael Francis | Geschäftsführer | 23 Knightsbridge Court CH1 1QG Chester | Uk | British | Chairman | 45725420009 | ||||||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 149939610001 | ||||||||
EGAN, Scott | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 170703910001 | ||||||||
EROTOCRITOU, Antonios | Geschäftsführer | Minster Court EC3R 7AA London 1 United Kingdom | United Kingdom | Cypriot | Deputy Cfo | 167795710001 | ||||||||
EVANS, Ieuan Cennydd | Geschäftsführer | Ysgubor Goch Llandough CF71 7LR Cowbridge Vale Of Glamorgan | Wales | British | Director | 66329000004 | ||||||||
HAGGETT, Linda | Geschäftsführer | Graig Y Mynydd CF39 8FD Thomastown 51 Tonyrefail | United Kingdom | Welsh | Insurance Broker | 137893590001 | ||||||||
HODGES, Mark Steven | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Director | 58444370003 | ||||||||
JOHNSON, Timothy David | Geschäftsführer | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | Company Director | 129538180001 | ||||||||
LYONS, Alastair David | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | England | British | Executive Chairman | 193700540001 | ||||||||
MUGGE, Mark Stephen | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent | England | British | Director | 162920630005 | ||||||||
PARK, Bryan | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 113694470002 | ||||||||
POWELL, Kenneth John | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | Wales | British | Director | 27317930001 | ||||||||
RAGAN, Paul Robert | Geschäftsführer | Tregyrnog Farmhouse St. Brides-Super-Ely CF5 6EZ Cardiff Vale Of Glamorgan | United Kingdom | British | Managing Director | 60263070005 | ||||||||
REA, Michael Peter | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 147194830001 | ||||||||
RIDEWOOD, Gary Spencer | Geschäftsführer | Leigh Cottage Mount Road CF64 4DG Dinas Powys South Glamorgan | Wales | British | Finance Director | 112745560001 | ||||||||
WIGLEY, William George | Geschäftsführer | 46 Heol St Cattwg Pendoylan CF71 7UG Cowbridge South Glamorgan | Wales | British | Director | 193333870002 | ||||||||
KTS NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | The Counting House Dunleavy Drive CF11 0SN Cardiff | 84474580001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protectagroup Acquisitions Limited | 06. Apr. 2016 | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 02. Apr. 2015 Geliefert am 22. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage all legal interest in trademark registration/application number 2413912 as listed in schedule 5 (intellectual property) of the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 10. Mai 2013 Geliefert am 23. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Pursuant to clause 3.1(b)(vii) of the charge, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property, including the following:. Trademark registration/application number 2413912.. pursuant to the charge, the company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed | Erstellt am 27. Juni 2012 Geliefert am 07. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2012 Geliefert am 06. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2010 Geliefert am 18. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession | Erstellt am 04. Juni 2008 Geliefert am 17. Juni 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Sept. 2006 Geliefert am 04. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Okt. 2004 Geliefert am 20. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 06. Okt. 2004 Geliefert am 21. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0