STONE GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTONE GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05088374
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STONE GROUP LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich STONE GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Granite One Hundred
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von STONE GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GW 3126 LIMITED30. März 200430. März 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STONE GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für STONE GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ verlegt

    1 SeitenAD03

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 12. Mai 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Granite One Hundred Acton Gate Stafford Staffordshire ST18 9AA verlegt

    1 SeitenAD04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    38 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 17. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Mai 2015

    • Kapital: GBP 1,252,377
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Simon Richard Harbridge am 06. März 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Juni 2014

    • Kapital: GBP 1,252,377
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Simon Richard Harbridge am 03. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Peter Reginald Berks am 03. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 18 Chalfont Road Maplecross Rickmansworth WD3 9TB* am 04. Juni 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    13 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 33 Whitecroft Road Luton Bedfordshire LU2 0JS* am 08. Aug. 2013

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Granite One Hundred Acton Gate Stafford Staffordshire ST18 9AA* am 19. Juni 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Änderung der Details des Direktors für Peter Reginald Berks am 03. Mai 2013

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von STONE GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    British176573280001
    BERKS, Peter Reginald
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish141072000001
    CONSTANTINIDES, Sotos
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish124622460002
    HARBRIDGE, Simon Richard
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish105161460006
    BIRCH, Elizabeth
    15 Nursery Way
    ST18 0FY Great Haywood
    Staffordshire
    Sekretär
    15 Nursery Way
    ST18 0FY Great Haywood
    Staffordshire
    British105161330001
    HARBRIDGE, Simon Richard
    Marlbrook Lane
    Sale Green
    WR9 7LW Droitwich
    Charlbury House
    Worcestershire
    Sekretär
    Marlbrook Lane
    Sale Green
    WR9 7LW Droitwich
    Charlbury House
    Worcestershire
    British105161460002
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    BIRD, Ronald James
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Acton Gate
    ST18 9AA Stafford
    Granite One Hundred
    Staffordshire
    UkBritish129727420002
    CAPEWELL, Colin John
    Allens Croft
    Marchington
    ST14 8PX Uttoxeter
    7
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Allens Croft
    Marchington
    ST14 8PX Uttoxeter
    7
    Staffordshire
    EnglandBritish138766880001
    HARRISON, Anthony James
    11 Attingham Drive
    WS11 2YB Cannock
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    11 Attingham Drive
    WS11 2YB Cannock
    Staffordshire
    British67231170001
    KAZEROUNIAN, Seyed Abdul Reza
    73a Hartwell Road
    Long Street Hanslope
    MK19 7BY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    73a Hartwell Road
    Long Street Hanslope
    MK19 7BY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118333280001
    MATTHEWS, Richard
    30 Darnford Moors
    WS14 9RL Lichfield
    Geschäftsführer
    30 Darnford Moors
    WS14 9RL Lichfield
    United KingdomBritish58335840002
    PETTIT, Simon
    Church View Barn
    ST20 0QB Adbaston
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Church View Barn
    ST20 0QB Adbaston
    Staffordshire
    United KingdomBritish184217030001
    RUSSELL, James
    34 Hazel Avenue
    WR11 1XT Eavesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    34 Hazel Avenue
    WR11 1XT Eavesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish111890860001
    TEMPLE, John
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    Geschäftsführer
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    British62721620002
    WILCOX, David Alan
    76 Wellington Road
    Muxton
    TF2 8NZ Telford
    Shropshire
    Geschäftsführer
    76 Wellington Road
    Muxton
    TF2 8NZ Telford
    Shropshire
    EnglandBritish61124810003
    GW INCORPORATIONS LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    68279000003

    Hat STONE GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Accession deed
    Erstellt am 04. Apr. 2008
    Geliefert am 10. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Simon Harbridge (The Lender)
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Wilcox (The Lender)
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jamie Russell (The Lender)
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anthony James Harrison (The Lender)
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stephen Grocott and Philip Taylor, as Trustee for the Ron Bird Discretionary Trust (The Lender)
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Own account assignment of life policy
    Erstellt am 03. Feb. 2005
    Geliefert am 19. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number H181681501 bupa health assurance limited on the life of richard matthews together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Own account assignment of life policy
    Erstellt am 03. Feb. 2005
    Geliefert am 19. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number H181676701 bupa health assurance limited on the life of david wilcox together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 2005
    Geliefert am 19. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 03. Feb. 2005
    Geliefert am 19. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the right,title and interest of the company in and to the acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Own account assignment of life policy
    Erstellt am 03. Feb. 2005
    Geliefert am 19. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number H181691201 bupa health assurance limited on the life of anthony harrison together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Own account assignment of life policy
    Erstellt am 03. Feb. 2005
    Geliefert am 19. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number H181686401 bupa health assurance limited life assured simon petit together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Feb. 2005
    Geliefert am 08. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the investors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a omega house emerald way stone business park emerald way stone staffordshire t/no SFZ593945. All other property and all interests in property, all computers vehicles office equipment, all charged securities, the security accounts, the intellectual property, the benefit of licences and the goodwill and uncalled capital. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cavendish Nominees Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0