STONE GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | STONE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05088374 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STONE GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich STONE GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Granite One Hundred Acton Gate ST18 9AA Stafford Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von STONE GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GW 3126 LIMITED | 30. März 2004 | 30. März 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STONE GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STONE GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Granite One Hundred Acton Gate Stafford Staffordshire ST18 9AA verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 38 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Aug. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Richard Harbridge am 06. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Richard Harbridge am 03. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Reginald Berks am 03. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 18 Chalfont Road Maplecross Rickmansworth WD3 9TB* am 04. Juni 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 33 Whitecroft Road Luton Bedfordshire LU2 0JS* am 08. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Granite One Hundred Acton Gate Stafford Staffordshire ST18 9AA* am 19. Juni 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Reginald Berks am 03. Mai 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STONE GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANTINIDES, Sotos | Sekretär | Acton Gate ST18 9AA Stafford Granite One Hundred Staffordshire United Kingdom | British | 176573280001 | ||||||
| BERKS, Peter Reginald | Geschäftsführer | Acton Gate ST18 9AA Stafford Granite One Hundred Staffordshire United Kingdom | England | British | 141072000001 | |||||
| CONSTANTINIDES, Sotos | Geschäftsführer | Acton Gate ST18 9AA Stafford Granite One Hundred Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 124622460002 | |||||
| HARBRIDGE, Simon Richard | Geschäftsführer | Acton Gate ST18 9AA Stafford Granite One Hundred Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 105161460006 | |||||
| BIRCH, Elizabeth | Sekretär | 15 Nursery Way ST18 0FY Great Haywood Staffordshire | British | 105161330001 | ||||||
| HARBRIDGE, Simon Richard | Sekretär | Marlbrook Lane Sale Green WR9 7LW Droitwich Charlbury House Worcestershire | British | 105161460002 | ||||||
| GW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710001 | |||||||
| BIRD, Ronald James | Geschäftsführer | Acton Gate ST18 9AA Stafford Granite One Hundred Staffordshire | Uk | British | 129727420002 | |||||
| CAPEWELL, Colin John | Geschäftsführer | Allens Croft Marchington ST14 8PX Uttoxeter 7 Staffordshire | England | British | 138766880001 | |||||
| HARRISON, Anthony James | Geschäftsführer | 11 Attingham Drive WS11 2YB Cannock Staffordshire | British | 67231170001 | ||||||
| KAZEROUNIAN, Seyed Abdul Reza | Geschäftsführer | 73a Hartwell Road Long Street Hanslope MK19 7BY Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 118333280001 | |||||
| MATTHEWS, Richard | Geschäftsführer | 30 Darnford Moors WS14 9RL Lichfield | United Kingdom | British | 58335840002 | |||||
| PETTIT, Simon | Geschäftsführer | Church View Barn ST20 0QB Adbaston Staffordshire | United Kingdom | British | 184217030001 | |||||
| RUSSELL, James | Geschäftsführer | 34 Hazel Avenue WR11 1XT Eavesham Worcestershire | United Kingdom | British | 111890860001 | |||||
| TEMPLE, John | Geschäftsführer | 3 Victoria Crescent Queens Park CH4 7AX Chester | British | 62721620002 | ||||||
| WILCOX, David Alan | Geschäftsführer | 76 Wellington Road Muxton TF2 8NZ Telford Shropshire | England | British | 61124810003 | |||||
| GW INCORPORATIONS LIMITED | Geschäftsführer | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 68279000003 |
Hat STONE GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed | Erstellt am 04. Apr. 2008 Geliefert am 10. Apr. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Jan. 2007 Geliefert am 31. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Own account assignment of life policy | Erstellt am 03. Feb. 2005 Geliefert am 19. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number H181681501 bupa health assurance limited on the life of richard matthews together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Own account assignment of life policy | Erstellt am 03. Feb. 2005 Geliefert am 19. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number H181676701 bupa health assurance limited on the life of david wilcox together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Feb. 2005 Geliefert am 19. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 03. Feb. 2005 Geliefert am 19. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the right,title and interest of the company in and to the acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Own account assignment of life policy | Erstellt am 03. Feb. 2005 Geliefert am 19. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number H181691201 bupa health assurance limited on the life of anthony harrison together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Own account assignment of life policy | Erstellt am 03. Feb. 2005 Geliefert am 19. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number H181686401 bupa health assurance limited life assured simon petit together with all amounts (including bonuses) to be paid under it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 03. Feb. 2005 Geliefert am 08. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the investors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a omega house emerald way stone business park emerald way stone staffordshire t/no SFZ593945. All other property and all interests in property, all computers vehicles office equipment, all charged securities, the security accounts, the intellectual property, the benefit of licences and the goodwill and uncalled capital. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0