KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED

KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05093211
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O GRANT THORNTON UK LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CRESTNORTH LIMITED05. Apr. 200405. Apr. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis04. Juli 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Mai 2011

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 03. Mai 2011

    11 Seiten2.35B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Mai 2010

    10 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Robert Brook als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Verschiedenes

    Duplicate form TMO1 for mr a white coy no 5093211
    2 SeitenMISC

    Beendigung der Bestellung von Andrew White als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Kennedy als Geschäftsführer

    4 SeitenTM01

    Vorschlag des Verwalters

    18 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 58 Davies Street London W1K 5JF am 04. Dez. 2009

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    4 SeitenMG02

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sect 175(5) 15/12/2008
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 04. Juli 2008

    14 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006

    12 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Sekretär
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Geschäftsführer
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    Hat KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security interest agreement
    Erstellt am 17. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns title to the collateral being the units and all the company's right, title and interest from time to time to and in all such securities and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee of Thesecurity Documents for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Nov. 2004
    Geliefert am 05. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the conpany to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 02. Nov. 2004
    Geliefert am 05. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the conpany to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 05. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the conpany to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assets: the whole of the property (including the uncalled capital) comprised in the property and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat KENMORE CAPITAL ALFRETON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Mai 2011Ende der Verwaltung
    12. Nov. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Caven
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    Praktiker
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0