WFA (UK) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WFA (UK) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05096119 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WFA (UK) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WFA (UK) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Acorn Business Centre Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth Hampshire England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WFA (UK) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ALL GEAR HOLDINGS LIMITED | 06. Apr. 2004 | 06. Apr. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WFA (UK) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WFA (UK) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul James Overall am 01. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Blake am 01. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Grant David Bartholomew am 01. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Cessation of The Taylor Cocks Partnership Limited as a person with significant control on 30. Apr. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Taylorcocks Group Ltd as a person with significant control on 30. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of The Taylor Cocks Partnership Limited as a person with significant control on 22. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 1 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 teilweise | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Adam Christopher Suffolk als Direktor am 22. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Grant David Bartholomew als Direktor am 22. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul James Overall als Direktor am 22. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Adam Keyes als Direktor am 22. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Abbey House, Hickleys Court South Street Farnham Surrey GU9 7QQ zum 3 Acorn Business Centre Northarbour Road Cosham Portsmouth Hampshire PO6 3th am 03. Jan. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Steven Beaumont am 12. Apr. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Blake am 12. Apr. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WFA (UK) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCKLAND, Miles Andrew Nicholas | Sekretär | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | British | 106088710002 | ||||||
AUCKLAND, Miles Andrew Nicholas | Geschäftsführer | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 106088710002 | ||||
BARTHOLOMEW, Grant David | Geschäftsführer | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | United Kingdom | British | Accountant | 216931610002 | ||||
BEAUMONT, Steven | Geschäftsführer | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 133694020004 | ||||
BLAKE, James Martin | Geschäftsführer | Acorn Business Centre Northarbour Road PO6 3TH Cosham 3 Portsmouth United Kingdom | England | British | Accountant | 226799730001 | ||||
KEYES, Richard Adam | Geschäftsführer | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | England | British | Director | 223353410001 | ||||
OVERALL, Paul James | Geschäftsführer | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | England | British | Accountant | 244114240001 | ||||
SUFFOLK, Adam Christopher | Geschäftsführer | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire England | United Kingdom | British | Chartered Tax Adviser | 216771160001 | ||||
RAPLEY, Linda Susan | Sekretär | 40 Keephatch Road RG40 1QJ Wokingham Berkshire | British | 93229000001 | ||||||
COOPER, Stephen David | Geschäftsführer | 10 Benbricke Green RG42 2EU Bracknell Berkshire | England | British | Director | 93229070001 | ||||
DAY, Stephen James | Geschäftsführer | 30 Brook Hill OX20 1JE Woodstock Oxfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 87073250002 | ||||
KYLE, Christopher | Geschäftsführer | Acorn Business Centre, Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 51051250001 | ||||
RAPLEY, Linda Susan | Geschäftsführer | 40 Keephatch Road RG40 1QJ Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 93229000001 | ||||
WALKER, Allison Victoria | Geschäftsführer | Acorn Business Centre Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Tax Advisor | 96313480001 | ||||
WEBB, Katharine Elizabeth | Geschäftsführer | 7 Winchester Road Four Marks GU34 5HD Alton Hampshire | British | Accountant | 106088530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WFA (UK) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylorcocks Group Ltd | 30. Apr. 2018 | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
The Taylor Cocks Partnership Limited | 22. Dez. 2017 | Northarbour Road Cosham PO6 3TH Portsmouth 3 Acorn Business Centre Hampshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Miles Andrew Nicholas Auckland | 06. Apr. 2016 | Acorn Business Centre, Northarbour Road PO6 3TH Portsmouth 3 England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Steven Beaumont | 06. Apr. 2016 | Acorn Business Centre, Northarbour Road PO6 3TH Portsmouth 3 England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr James Blake | 06. Apr. 2016 | Acorn Business Centre, Northarbour Road PO6 3TH Portsmouth 3 England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat WFA (UK) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge of securities(UK) | Erstellt am 22. Mai 2006 Geliefert am 07. Juni 2006 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on any stocks shares bonds warrants or securities (certified or uncertified) named in any schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 21. Dez. 2005 Geliefert am 23. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £60,000 credited to account designation number 36675547 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Dez. 2005 Geliefert am 21. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0