HCCAH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HCCAH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05096889 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HCCAH LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HCCAH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HCCAH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED | 01. Juni 2004 | 01. Juni 2004 |
| TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED | 06. Apr. 2004 | 06. Apr. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HCCAH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HCCAH LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HCCAH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Alexander Burrell als Direktor am 10. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 050968890008, erstellt am 12. Juni 2014 | 91 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Geraldine Josephine Gallagher als Direktor am 31. Jan. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Edward Bennison als Geschäftsführer am 31. Jan. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Edward Bennison als Sekretär am 31. Jan. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 11 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 18 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 14 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Edward Bennison als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Edward Bennison als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Doubleday als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HCCAH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURRELL, James Alexander | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | 192486560001 | |||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | Irish | 185108770001 | |||||
| HUNTER, Gail Susan | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 89557480002 | |||||
| TROY, Anthony Gerard | Geschäftsführer | Fountains Bent Darley Road, Bristwith HG3 2PN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 104500230001 | |||||
| BENNISON, Matthew Edward | Sekretär | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | 161805270001 | |||||||
| DOUBLEDAY, Timothy | Sekretär | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156121500001 | ||||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Sekretär | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | 185108770001 | ||||||
| SOLOMAN, Sheila Margaret | Sekretär | 5 The Green Hardingstone NN4 7BU Northampton Northamptonshire | British | 45253560008 | ||||||
| TRUSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
| ANDERSON, Peter George | Geschäftsführer | 23 Cheshire Road OX9 3LQ Thame Oxfordshire | British | 70304810001 | ||||||
| BELLONE, Norman Edward | Geschäftsführer | Gardens Cottage Bagendon GL7 7DU Cirencester Gloucestershire | British | 126414070001 | ||||||
| BENNISON, Matthew Edward | Geschäftsführer | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | 108534390002 | |||||
| DAY, Mark | Geschäftsführer | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | 124446000001 | |||||
| DOUBLEDAY, Timothy John | Geschäftsführer | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 91011320001 | |||||
| NISBETT, Paul Sandle | Geschäftsführer | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | 132613500001 | |||||
| PEEKE, Alexander | Geschäftsführer | 7 Milton Lodge Whitton Road TW1 1BU Twickenham | British | 98031180001 | ||||||
| STOKER, Louise Jane | Geschäftsführer | 2nd Floor Flat 45 Hillfield Road, West Hampstead NW6 1QD London | British | 96079800001 | ||||||
| WHITE, Graham Peter | Geschäftsführer | Copsem Lane KT22 0NT Oxshott Woodlands House Surrey | United Kingdom | British | 4934020002 | |||||
| ZUERCHER, Eleanor Jane | Geschäftsführer | 14 St Marys Court Tingewick MK18 4RE Buckingham Buckinghamshire | British | 61053330001 |
Hat HCCAH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 12. Juni 2014 Geliefert am 18. Juni 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| English law deed of accession | Erstellt am 27. Feb. 2013 Geliefert am 01. März 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2011 Geliefert am 10. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 18. Juni 2007 Geliefert am 22. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. März 2006 Geliefert am 06. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003 | Erstellt am 24. Jan. 2005 Geliefert am 02. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 18. Dez. 2003 Erworben am 24. Jan. 2005 Geliefert am 27. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders | |
Kurze Angaben Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 14. Jan. 2000 Erworben am 24. Jan. 2005 Geliefert am 03. Feb. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0