RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED

RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05098443
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED?

    • (2215) /

    Wo befindet sich RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Bridewell House
    Bridewell Lane
    TN30 6EP Tenterden
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WINDOWIMAGE LIMITED08. Apr. 200408. Apr. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    6 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Juni 2009

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Dez. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    7 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Dez. 2008

    7 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 08. Okt. 2007

    2 Seiten1.3

    Vermögensübersicht

    18 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Gründung des Liquidationsausschusses

    2 Seiten4.48

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    14 Seiten1.4

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 04. Juni 2007

    2 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 24. Apr. 2007

    2 Seiten1.3

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    10 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    10 Seiten1.1

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2005

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUGDEN, Deborah Joan
    107 Lower Road
    TN26 3SG Woodchurch
    Kent
    Sekretär
    107 Lower Road
    TN26 3SG Woodchurch
    Kent
    British113731870002
    BURTON, Simon David
    Swn Y Deryn Hendidley Way
    Milford Road
    SY16 2AL Newtown
    Powys
    Geschäftsführer
    Swn Y Deryn Hendidley Way
    Milford Road
    SY16 2AL Newtown
    Powys
    British97940170001
    MAY, Sharon Lynn
    27 Pittlesden
    TN30 6HJ Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    27 Pittlesden
    TN30 6HJ Tenterden
    Kent
    British97939810001
    BUGDEN, Deborah Joan
    81 Front Road
    Woodchurch
    TN26 3SF Ashford
    Kent
    Sekretär
    81 Front Road
    Woodchurch
    TN26 3SF Ashford
    Kent
    British113731870001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BUGDEN, Deborah Joan
    81 Front Road
    Woodchurch
    TN26 3SF Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    81 Front Road
    Woodchurch
    TN26 3SF Ashford
    Kent
    British113731870001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of debenture
    Erstellt am 08. Dez. 2006
    Geliefert am 14. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any associate on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of mortgage over land and chattels
    Erstellt am 08. Dez. 2006
    Geliefert am 14. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each associate on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h proeprty t/n K548009 known as unit 1E marley farm smarden ashford and the f/h property t/n WA880259 known as unit 41 mochdre enterprise park newtown, goodwill, the mortgages chattel assets, other fixed plant and machinery, floating charge all plant machinery goods and other assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Sept. 2004
    Geliefert am 18. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as unit 41 mochdre enterprise park newtown powys,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Sept. 2004
    Geliefert am 18. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as unit 1E marley farm headcorn road smarden kent,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 24. Aug. 2004
    Geliefert am 25. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Aug. 2004
    Geliefert am 26. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat RED BOOKS (ESTATE PUBLICATIONS) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Apr. 2006Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    04. Juni 2007Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Geoffrey William Rhodes
    Begbies Traynor
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Praktiker
    Begbies Traynor
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    2
    DatumTyp
    15. Jan. 2010Aufgelöst am
    11. Juni 2007Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Geoffrey William Rhodes
    Begbies Traynor
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Praktiker
    Begbies Traynor
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0