PLUM BABY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePLUM BABY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05100794
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PLUM BABY LIMITED?

    • Großhandel mit Obst und Gemüse (46310) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich PLUM BABY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o MAZARS LLP
    Tower Bridge House
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PLUM BABY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FORMBOND LIMITED13. Apr. 200413. Apr. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PLUM BABY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Juli 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PLUM BABY LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PLUM BABY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 27. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 2,781
    SH01

    Ernennung von Mr Richard Landers als Direktor am 17. März 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Juli 2013

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Old Boathouse Mill Lane Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0AA zum C/O Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD am 28. Nov. 2014

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Michael Meyer als Geschäftsführer am 01. Nov. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Juli 2014 bis 28. Jan. 2015

    1 SeitenAA01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2013 bis 28. Juli 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 2,781
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Neil Grimmer als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Michael Meyer als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Wotherspoon als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Burr als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von PLUM BABY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRIMMER, Neil
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    England
    UsaAmerican177143100001
    LANDERS, Richard
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    England
    Geschäftsführer
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    England
    United StatesAmerican183581970001
    JOHNSON, Andrew
    Clangers
    66 Church Street
    SP6 1BE Fordingbridge
    Hampshire
    Sekretär
    Clangers
    66 Church Street
    SP6 1BE Fordingbridge
    Hampshire
    British77539340001
    LANE, Andrew
    The Bittoms
    KT1 2AN Kingston Upon Thames
    55 Avante Court
    Surrey
    Sekretär
    The Bittoms
    KT1 2AN Kingston Upon Thames
    55 Avante Court
    Surrey
    British148480210001
    MASKELYNE, Elaine Louise
    Lake Road
    Chandler's Ford
    SO53 1EZ Eastleigh
    13
    Hampshire
    Sekretär
    Lake Road
    Chandler's Ford
    SO53 1EZ Eastleigh
    13
    Hampshire
    British132296380001
    WHITE, Conrad James
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    167737230001
    CLIFFORD FRY & CO (COMPANY SECRETARIAL) LTD
    St Mary's House
    Netherhampton
    SP2 8PU Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    St Mary's House
    Netherhampton
    SP2 8PU Salisbury
    Wiltshire
    82979690001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    ASHTON, Jason Russel Gary
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish161744260001
    BURR, Jonathan Richard
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish163025530001
    CAIRNS, Patrick David
    57 Westcroft Square
    W6 0TA London
    Geschäftsführer
    57 Westcroft Square
    W6 0TA London
    United KingdomBritish127975960001
    GLENN, Martin Richard
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    UkBritish61897350002
    GUEST, Christopher Robert
    Hunstanton Hall
    Church Road
    PE36 6JS Hunstanton
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Hunstanton Hall
    Church Road
    PE36 6JS Hunstanton
    Norfolk
    EnglandBritish31438630003
    KAYE, Paul Frederick
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish147658760001
    LANE, Andrew Gerard Hubert
    Avante Court The Bittoms
    KT1 2AN Kingston Upon Thames
    32,
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Avante Court The Bittoms
    KT1 2AN Kingston Upon Thames
    32,
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish34036930003
    MEYER, Michael
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    UsaAmerican177568050001
    SETH, Andrew
    Great Bainden
    Piccadilly Lane
    TN20 6RH Mayfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Great Bainden
    Piccadilly Lane
    TN20 6RH Mayfield
    East Sussex
    EnglandBritish33293390002
    WHITE, Nigel Philip
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish141660110003
    WILLIS, Patrick Thomas
    Cripstead Lane
    SO23 9SE Winchester
    12
    Hants
    Geschäftsführer
    Cripstead Lane
    SO23 9SE Winchester
    12
    Hants
    UkBritish130154100001
    WILLIS, Susanne
    Nether Wallop
    SO20 8DS Stockbridge
    Broughton Down Farmhouse
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Nether Wallop
    SO20 8DS Stockbridge
    Broughton Down Farmhouse
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish98180640002
    WOTHERSPOON, John Scott
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    Taplow
    SL6 0AA Maidenhead
    The Old Boathouse
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish And Australian167738730001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Hat PLUM BABY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 16. Apr. 2012
    Geliefert am 19. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all the other companies and limited liability partnerships to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Apr. 2012
    Geliefert am 21. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or project indigo topco limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Darwin Private Equity LLP on Behalf of and in Its Capacity as Manager of Darwin Private Equity I L.P.
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 13. März 2009
    Geliefert am 21. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 08. Feb. 2008
    Geliefert am 13. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re plum baby limited, current account, account number 40385352. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 03. Mai 2007
    Geliefert am 05. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any person under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fse Loan Management Limited
    Transaktionen
    • 05. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 08. Feb. 2007
    Geliefert am 16. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 11. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 11. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 12. Jan. 2006
    Geliefert am 17. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re plum baby limited and numbered 1639754 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 12. Jan. 2006
    Geliefert am 17. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0