PLUM BABY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PLUM BABY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05100794 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PLUM BABY LIMITED?
- Großhandel mit Obst und Gemüse (46310) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich PLUM BABY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o MAZARS LLP Tower Bridge House St. Katharines Way E1W 1DD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PLUM BABY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FORMBOND LIMITED | 13. Apr. 2004 | 13. Apr. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PLUM BABY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Juli 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PLUM BABY LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PLUM BABY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Landers als Direktor am 17. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 28. Juli 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Old Boathouse Mill Lane Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0AA zum C/O Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD am 28. Nov. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Meyer als Geschäftsführer am 01. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Juli 2014 bis 28. Jan. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2013 bis 28. Juli 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Grimmer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Meyer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Wotherspoon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Burr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PLUM BABY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIMMER, Neil | Geschäftsführer | c/o Mazars Llp St. Katharines Way E1W 1DD London Tower Bridge House England | Usa | American | 177143100001 | |||||
| LANDERS, Richard | Geschäftsführer | c/o Mazars Llp St. Katharines Way E1W 1DD London Tower Bridge House England | United States | American | 183581970001 | |||||
| JOHNSON, Andrew | Sekretär | Clangers 66 Church Street SP6 1BE Fordingbridge Hampshire | British | 77539340001 | ||||||
| LANE, Andrew | Sekretär | The Bittoms KT1 2AN Kingston Upon Thames 55 Avante Court Surrey | British | 148480210001 | ||||||
| MASKELYNE, Elaine Louise | Sekretär | Lake Road Chandler's Ford SO53 1EZ Eastleigh 13 Hampshire | British | 132296380001 | ||||||
| WHITE, Conrad James | Sekretär | Mill Lane Taplow SL6 0AA Maidenhead The Old Boathouse Berkshire United Kingdom | 167737230001 | |||||||
| CLIFFORD FRY & CO (COMPANY SECRETARIAL) LTD | Sekretär | St Mary's House Netherhampton SP2 8PU Salisbury Wiltshire | 82979690001 | |||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| ASHTON, Jason Russel Gary | Geschäftsführer | Mill Lane Taplow SL6 0AA Maidenhead The Old Boathouse Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 161744260001 | |||||
| BURR, Jonathan Richard | Geschäftsführer | Mill Lane Taplow SL6 0AA Maidenhead The Old Boathouse Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 163025530001 | |||||
| CAIRNS, Patrick David | Geschäftsführer | 57 Westcroft Square W6 0TA London | United Kingdom | British | 127975960001 | |||||
| GLENN, Martin Richard | Geschäftsführer | Manor House Stanford Dingley RG7 6LS Reading Berkshire | Uk | British | 61897350002 | |||||
| GUEST, Christopher Robert | Geschäftsführer | Hunstanton Hall Church Road PE36 6JS Hunstanton Norfolk | England | British | 31438630003 | |||||
| KAYE, Paul Frederick | Geschäftsführer | Mill Lane Taplow SL6 0AA Maidenhead The Old Boathouse Berkshire United Kingdom | England | British | 147658760001 | |||||
| LANE, Andrew Gerard Hubert | Geschäftsführer | Avante Court The Bittoms KT1 2AN Kingston Upon Thames 32, Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 34036930003 | |||||
| MEYER, Michael | Geschäftsführer | Mill Lane Taplow SL6 0AA Maidenhead The Old Boathouse Berkshire United Kingdom | Usa | American | 177568050001 | |||||
| SETH, Andrew | Geschäftsführer | Great Bainden Piccadilly Lane TN20 6RH Mayfield East Sussex | England | British | 33293390002 | |||||
| WHITE, Nigel Philip | Geschäftsführer | Mill Lane Taplow SL6 0AA Maidenhead The Old Boathouse Berkshire United Kingdom | England | British | 141660110003 | |||||
| WILLIS, Patrick Thomas | Geschäftsführer | Cripstead Lane SO23 9SE Winchester 12 Hants | Uk | British | 130154100001 | |||||
| WILLIS, Susanne | Geschäftsführer | Nether Wallop SO20 8DS Stockbridge Broughton Down Farmhouse Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 98180640002 | |||||
| WOTHERSPOON, John Scott | Geschäftsführer | Mill Lane Taplow SL6 0AA Maidenhead The Old Boathouse Berkshire United Kingdom | England | British And Australian | 167738730001 | |||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Hat PLUM BABY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 16. Apr. 2012 Geliefert am 19. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all the other companies and limited liability partnerships to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Apr. 2012 Geliefert am 21. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or project indigo topco limited to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed & floating charge | Erstellt am 13. März 2009 Geliefert am 21. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 08. Feb. 2008 Geliefert am 13. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re plum baby limited, current account, account number 40385352. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Mai 2007 Geliefert am 05. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any person under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Feb. 2007 Geliefert am 16. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 11. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 12. Jan. 2006 Geliefert am 17. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re plum baby limited and numbered 1639754 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 12. Jan. 2006 Geliefert am 17. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0