KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05120790 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Canal Mill Botany Brow PR6 9AF Chorley Lancashire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GLANMORE COOMBE HILL HOUSE LIMITED | 25. Okt. 2004 | 25. Okt. 2004 |
SDG (NEW MALDEN 1) LIMITED | 29. Juni 2004 | 29. Juni 2004 |
DWSCO 2526 LIMITED | 06. Mai 2004 | 06. Mai 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2015 bis 30. Jan. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2014 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2012 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Dixon als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gerald Wood als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Claire Caroline Sharp als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carrie Sharp als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARP, Claire Caroline | Sekretär | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | British | Property Director | 141979130001 | |||||
HOPKINSON, Thomas Duncan | Geschäftsführer | Bank House Sawley Road Sawley BB7 4RS Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 71862660002 | ||||
KNOWLES, Timothy John Peter | Geschäftsführer | Clogh Willey Cottage Tosaby Road Stoney Mountain IM9 3AN St Marks Isle Of Man | Isle Of Man | British | Director | 33274370003 | ||||
SHARP, Claire Caroline | Geschäftsführer | Botany Brow PR6 9AF Chorley Canal Mill Lancashire | England | British | Property Director | 141979130001 | ||||
JENKINSON, Jayne Elizabeth | Sekretär | Inglemere Langley Lane, Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | British | 85366800001 | ||||||
SHARP, Claire Caroline | Sekretär | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | British | Secretary | 141979130001 | |||||
DWS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023840001 | |||||||
INVESTEC ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Sekretär | PO BOX 52 Investec House La Plaiderie St Peter Port GY1 3BJ Guernsey Channel Islands | 100177760001 | |||||||
TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 93 George Street EH2 3ES Edinburgh | 90707230001 | |||||||
DI CIACCA, Cesidio Martin | Geschäftsführer | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | Consultant | 1267050001 | ||||
DIXON, William Ronald | Geschäftsführer | Cumberland Drive WA14 3QP Bowdon 27 Cheshire | England | British | Finance Director | 136501510001 | ||||
HOWAT, Andrew Russell | Geschäftsführer | Ventris House La Bridage Road St Andrews GY6 8RQ Guernsey Channel Islands | British | Managing Director | 118987510001 | |||||
JENKINSON, Jayne Elizabeth | Geschäftsführer | Inglemere Langley Lane, Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | England | British | Financial Controller | 85366800001 | ||||
LEWIS, Janine | Geschäftsführer | Coco De Mer Folioe Lane GY3 5SD Vale Guernsey Channel Islands | British | Supervisor Investor Services | 100577840001 | |||||
MCBRIDE, Stephen Paul | Geschäftsführer | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | Financial Director | 56953000002 | ||||
MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | Surveyor | 109250000001 | |||||
MCCABE, Simon Charles | Geschäftsführer | 5 Rothesay Mews EH3 7SG Edinburgh | British | Company Director | 103888320001 | |||||
MCKEAN, Michael | Geschäftsführer | Newhaven, Rue De Bouverie GY5 7TZ Castel Channel Islands | British | Company Director | 100219600001 | |||||
SHARP, Carrie | Geschäftsführer | The Croft Lower Simpson Fold Blackburn Road PR6 8HL Higher Wheelton Chorley Lancashire | England | British | Property Management | 124558490001 | ||||
TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | Chartered Surveyor | 69909950001 | ||||
WOOD, Gerald Jospeh | Geschäftsführer | 1 Stanley Road Farington PR25 4RH Leyland Lancashire | England | British | General Manager | 110948700001 | ||||
DWS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Five Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900023830001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Industrial Limited | 06. Apr. 2016 | Botany Bay PR6 9AF Chorley Botany Bay England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat KNOWLES INDUSTRIAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2006 Geliefert am 17. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
English security agreement | Erstellt am 14. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Juli 2004 Geliefert am 23. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Coombe hill house, coombe lane, new maiden t/n SGL649187. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Juli 2004 Geliefert am 23. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0