PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05131340 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southport Business Park Wight Moss Way PR8 4HQ Southport United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
EVER 2403 LIMITED | 18. Mai 2004 | 18. Mai 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Emma Jane Rawlinson als Direktor am 13. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Rebecca Jane Shepherd als Direktor am 13. Apr. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Byrne als Geschäftsführer am 01. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 215 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Mai 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dean Clarke als Sekretär am 22. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Ardonagh Corporate Secretary Limited als Sekretär am 22. Feb. 2022 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 195 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 01. Juli 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Minster Court Mincing Lane EC3R 7PD London 2 United Kingdom |
| 288842300001 | ||||||||||
EVANS, Robert Ieuan | Geschäftsführer | Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Southport Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 257339940001 | ||||||||
RAWLINSON, Emma Jane | Geschäftsführer | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 308195960001 | ||||||||
SHEPHERD, Rebecca Jane | Geschäftsführer | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom United Kingdom | England | British | Company Director | 191546550001 | ||||||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 169016440001 | |||||||||||
CLARKE, Dean | Sekretär | Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Southport Business Park United Kingdom | 253940220001 | |||||||||||
EVANS, Paul William John | Sekretär | 2 Stokes Hall Avenue Leyland PR25 3FA Preston Lancashire | British | 44044870002 | ||||||||||
GIFFORD, Nicola | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 147962050001 | |||||||||||
GOURIET, Geoffrey Costerton | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 249087370001 | |||||||||||
GREGORY, Jacqueline Anne | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 222330450001 | |||||||||||
JOHNSTON, Graham Hamilton | Sekretär | 13 Glencairn Park Road GL50 2ND Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 120581050001 | |||||||||
OWENS, Jennifer | Sekretär | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 183285380001 | |||||||||||
PENDER, Stuart Macpherson | Sekretär | Dalnair House 47 Chalton Road FK9 4EF Bridge Of Allan Stirlingshire | British | Company Director | 86071320001 | |||||||||
POWELL, Vernon David | Sekretär | 18 Sunnybank Road Helmshore BB4 4PF Rossendale Lancashire | British | 65823910002 | ||||||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||||||
BOULGER, Graham | Geschäftsführer | 2 Church Gardens Euxton PR7 6LF Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 85225620001 | ||||||||
BYRNE, Jonathan | Geschäftsführer | Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Southport Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 261430150001 | ||||||||
CHRISTOPHERS, Michael | Geschäftsführer | 7 Chiltern Close Park Hill CR0 5LZ Croydon Surrey | British | Company Director | 56738180003 | |||||||||
COWAN, John | Geschäftsführer | 47 Montagu Square W1H 2LW London | United Kingdom | British | Director | 109138540001 | ||||||||
CULLUM, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 59873490009 | ||||||||
DAVIES, Mark | Geschäftsführer | 12 Pinfold Lane PR8 3QH Ainsdale Merseyside | British | Human Resources Director | 117122470001 | |||||||||
DIXON, Richard John | Geschäftsführer | 6 Woodthorpe Manor Sandal WF2 6SY Wakefield West Yorkshire | England | British | Operations Director | 109138230001 | ||||||||
EGAN, Scott | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 169209310001 | ||||||||
EROTOCRITOU, Antonios | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | Cypriot | Deputy Cfo | 167795710001 | ||||||||
EVANS, Paul William John | Geschäftsführer | 2 Stokes Hall Avenue Leyland PR25 3FA Preston Lancashire | British | Accountant | 44044870002 | |||||||||
HODGES, Mark Steven | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 58444370003 | ||||||||
HOMER, Andrew Charles | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | Director | 13483140003 | ||||||||
JOHNSON, Timothy David | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | Director | 140206600001 | ||||||||
JOHNSTON, Graham Hamilton | Geschäftsführer | 13 Glencairn Park Road GL50 2ND Cheltenham Gloucestershire | England | British | Compliance Director | 120581050001 | ||||||||
KENNEDY, Eamonn | Geschäftsführer | 18 Lyme Road Disley SK12 2LL Stockport | England | British | Director | 75039450002 | ||||||||
LANE SMITH, Roger | Geschäftsführer | The Lanebridge Property Fund The Coach House Fulshaw Hall SK9 1RL Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 109062130001 | ||||||||
LYONS, Alastair David | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Executive Chairman | 192311310001 | ||||||||
MACIVER, Kenneth | Geschäftsführer | The Poplars The Green TN12 8JS Horsmonden Kent | British | Company Director | 70920700002 | |||||||||
MARTIN, Kay Alison | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | Director | 228129420001 | ||||||||
MUGGE, Mark Stephen | Geschäftsführer | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | Director | 162920630005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paymentshield Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Southport Business Park United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 10. Juni 2020 Geliefert am 18. Juni 2020 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 26. Sept. 2018 Geliefert am 01. Okt. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 07. Aug. 2017 Geliefert am 10. Aug. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 02. Apr. 2015 Geliefert am 22. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 10. Mai 2013 Geliefert am 20. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2012 Geliefert am 06. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Feb. 2011 Geliefert am 25. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession | Erstellt am 29. Juni 2009 Geliefert am 13. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Apr. 2009 Geliefert am 06. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2006 Geliefert am 14. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Nov. 2006 Geliefert am 14. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Aug. 2004 Geliefert am 25. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash collateral account | Erstellt am 13. Aug. 2004 Geliefert am 25. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the lng bank under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any credit balance on the secured account number 06037903 sort code 12-08-95 and all entitlements to interest the right to repayment and all other rights benefits and proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0