DF (VANTAGE PARK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDF (VANTAGE PARK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05134563
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DF (VANTAGE PARK) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich DF (VANTAGE PARK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7 Whiteladies Road
    Clifton
    BS8 1NN Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DF (VANTAGE PARK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DEELEY FREED (VANTAGE PARK) LIMITED21. Mai 200421. Mai 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DF (VANTAGE PARK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DF (VANTAGE PARK) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für DF (VANTAGE PARK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 24. Mai 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 26. Mai 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 21. Mai 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Anthony William Deeley am 28. Feb. 2014

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Mark Tyrrell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    6 SeitenMEM/ARTS

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    The facilities agreement to be entered into between the company 13/04/2012
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    9 SeitenMG01

    legacy

    12 SeitenMG01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    Wer sind die Geschäftsführer von DF (VANTAGE PARK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRIGGS, Philip Neil
    5a Manor Road
    Saltford
    BS31 3DL Bristol
    Jubaral
    United Kingdom
    Sekretär
    5a Manor Road
    Saltford
    BS31 3DL Bristol
    Jubaral
    United Kingdom
    British92356630002
    DEELEY, Peter Anthony William
    Longbourne Farm
    Pittern Hill
    CV35 0JF Kineton
    Pemberley
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    Longbourne Farm
    Pittern Hill
    CV35 0JF Kineton
    Pemberley
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish45739970003
    FREED, David Maxwell
    101 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3EE Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    101 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3EE Bristol
    Avon
    United KingdomBritish104531260001
    MALTBY, Andrew Dexter
    Kingsway Barn
    Corston
    SN16 0HW Malmesbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Kingsway Barn
    Corston
    SN16 0HW Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish67587010001
    NELSON, Rachael
    71 Heathfields
    Downend
    BS16 6HT Bristol
    Sekretär
    71 Heathfields
    Downend
    BS16 6HT Bristol
    British85983260001
    TYRRELL, Mark John
    6 Market Place
    Marshfield
    SN14 8NP Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    6 Market Place
    Marshfield
    SN14 8NP Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish66791740001

    Hat DF (VANTAGE PARK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2012
    Geliefert am 27. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The specified investments and the related rights. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Lender)
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2012
    Geliefert am 24. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the specified investments and the rights pertaining to them see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deeley Freed Estates Limited
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2008
    Geliefert am 24. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deeley Freed Estates Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 2008
    Geliefert am 24. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land t/no. GR276977 k/a land at vantage park old gloucester road hambrook all its presents and future right, title and interest in or to the property; and by way of fixed charge all proceeds of sale of the whole or any part of the property and all fittings at any time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Deeley Freed Estates Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2008
    Geliefert am 23. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 2008
    Geliefert am 23. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at vantage park old gloucester road hambrook t/no GR276977 all buildings erections fixtures and fixed plant and machinery all easements see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of security assignment of a project agreement
    Erstellt am 25. Jan. 2005
    Geliefert am 15. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The contract being the agreement dated 25 january 2005 between the company and the counterparty. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Sept. 2004
    Geliefert am 05. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Vantage park, old gloucester road, hambrook, bristol t/no GR261585 (part). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Sept. 2004
    Geliefert am 29. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0